WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামWALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03518803
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ক্রুড পেট্রোলিয়ামের নিষ্কাশন (06100) / খনিজ এবং কোয়ারিং

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    One
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ENDEAVOUR NORTH SEA LIMITED২১ নভে, ২০০৬২১ নভে, ২০০৬
    TALISMAN EXPRO LIMITED১৯ ডিসে, ২০০৫১৯ ডিসে, ২০০৫
    PALADIN EXPRO LIMITED১৩ জানু, ২০০০১৩ জানু, ২০০০
    PALADIN RESOURCES (BITTERN) LIMITED০২ সেপ, ১৯৯৮০২ সেপ, ১৯৯৮
    LUDGATE 162 LIMITED২৭ ফেব, ১৯৯৮২৭ ফেব, ১৯৯৮

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০১৯
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২০
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৮

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২৭ ফেব, ২০২১
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১০ এপ্রি, ২০২১
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২৭ ফেব, ২০২০
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ১৫ মে, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Matthew Mulcahy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৫ মে, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৫ মে, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Erik Brodahl এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৫ মে, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jon Bard Skabo এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ এপ্রি, ২০২৫ তারিখে Jon Bard Skabo-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৩ এপ্রি, ২০২৫ তারিখে Mr Erik Brodahl-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ এপ্রি, ২০২২ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Waldorf Production Uk Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ২৪ নভে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jon Bard Skabo-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৪ নভে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Martyn Roger Tanner-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৪ নভে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Erik Brodahl-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ২৯ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Erik Brodahl এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৯ জানু, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jon Bard Skabo এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    Mr Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati কে পরিচালক হিসাবে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    3 পৃষ্ঠাRP04AP01

    ২৭ ফেব, ২০২০ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ২৯ নভে, ২০১৯ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Endeavour Energy Uk Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name২৯ নভে, ২০১৯

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২৮ নভে, ২০১৯

    RES15

    ২২ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Erik Brodahl-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২২ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Venkata Vardhana Aaditya Chintalapati-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১১ জানু, ২০২১Second Filing A second filed AP01 was registered on 11.01.2021.

    ২২ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Jon Bard Skabo-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২২ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Catherine L. Stubbs এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ নভে, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Vinson & Elkins Rllp 24th Floor 20 Fenchurch Street London EC3M 3BY England থেকে One St Peter's Square Manchester M2 3DEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MULCAHY, Matthew
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    ScotlandEnglish206522020001
    TANNER, Paul Martyn Roger
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish287235120001
    CRAW, Jaquelynn Forsyth
    54 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    সচিব
    54 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British109665360001
    ELLAM, Robert James
    Sycamore House Rectory Road
    Hampton Bishop
    HR1 4JU Hereford
    Herefordshire
    সচিব
    Sycamore House Rectory Road
    Hampton Bishop
    HR1 4JU Hereford
    Herefordshire
    British59115350001
    PAGANIS, Karen
    6426 Eaglewood Green Lane
    Spring
    Harris
    Tx 77379
    Usa
    সচিব
    6426 Eaglewood Green Lane
    Spring
    Harris
    Tx 77379
    Usa
    British126751310001
    POWELL, Sally Caroline
    Park Farm Barn
    Church Lane
    WR2 6PF Hallow
    Worcestershire
    সচিব
    Park Farm Barn
    Church Lane
    WR2 6PF Hallow
    Worcestershire
    British73499120003
    TEAGUE, Don
    2200 Willowick \ 16d
    Houston
    Texas
    77027
    Usa
    সচিব
    2200 Willowick \ 16d
    Houston
    Texas
    77027
    Usa
    American116981530001
    LUDGATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    900013900001
    BRODAHL, Erik
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    NorwayNorwegian259915260001
    BRODAHL, Erik
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    NorwayNorwegian289176780001
    BUCKEE, James William
    240/40th Avenue Sw
    Calgary
    Alberta
    T2s 0x3
    Canada
    পরিচালক
    240/40th Avenue Sw
    Calgary
    Alberta
    T2s 0x3
    Canada
    British46195090001
    CHINTALAPATI, Venkata Vardhana Aaditya
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    EnglandBritish242565870001
    CRAW, Jaquelynn Forsyth
    54 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    পরিচালক
    54 Beaconsfield Place
    AB15 4AJ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British109665360001
    DAVISON, Paul
    Selwood Rickford
    Worplesdon
    GU3 3PJ Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    Selwood Rickford
    Worplesdon
    GU3 3PJ Guildford
    Surrey
    British59343700002
    FITZPATRICK, Robert Francis Trew
    Broad Hinton House
    Broad Hinton
    SN4 9PA Swindon
    Wiltshire
    পরিচালক
    Broad Hinton House
    Broad Hinton
    SN4 9PA Swindon
    Wiltshire
    EnglandBritish95621990001
    FRANKLIN, Roy Alexander
    Culmer Farm House
    Petworth Road,Wormley
    GU8 5SW Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Culmer Farm House
    Petworth Road,Wormley
    GU8 5SW Godalming
    Surrey
    British5667230002
    GRENZ, Carl
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9UE London
    Citypoint 33rd Floor
    পরিচালক
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9UE London
    Citypoint 33rd Floor
    UkBritish146425220001
    GRIFFITHS, David
    Merrydawns
    Meadowside
    KT23 3LG Great Bookham
    Surrey
    পরিচালক
    Merrydawns
    Meadowside
    KT23 3LG Great Bookham
    Surrey
    British115393840001
    MCDOWELL, Cuthbert John
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    পরিচালক
    Down Street
    W1J 7AJ London
    7
    United KingdomBritish54783520001
    MITHEN, David Patrick
    Carpe Diem House Daviot
    AB51 0HZ Inverurie
    Aberdeenshire
    পরিচালক
    Carpe Diem House Daviot
    AB51 0HZ Inverurie
    Aberdeenshire
    British60585460001
    MUNNS, James William
    31 Chantry Hurst
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    পরিচালক
    31 Chantry Hurst
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    EnglandBritish96456540001
    POWELL, Sally Caroline
    Park Farm Barn
    Church Lane
    WR2 6PF Hallow
    Worcestershire
    পরিচালক
    Park Farm Barn
    Church Lane
    WR2 6PF Hallow
    Worcestershire
    UkBritish73499120003
    REID, Colin John Watson
    6 Moray Place
    AB15 4AF Aberdeen
    পরিচালক
    6 Moray Place
    AB15 4AF Aberdeen
    ScotlandBritish87210540002
    SHEPPARD, Mary Jacqueline
    1316 Prospect Avenue Sw
    Calgary
    T2T OX5 Alberta
    Canada
    পরিচালক
    1316 Prospect Avenue Sw
    Calgary
    T2T OX5 Alberta
    Canada
    Canadian47103050001
    SKABO, Jon Bard
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    NorwayNorwegian304275580001
    SKABO, Jon Bard
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    NorwayNorwegian289179680001
    STUBBS, Catherine L.
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    United Kingdom
    United StatesAmerican167197320001
    WALKER, Nicholas John Robert
    3 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    পরিচালক
    3 Kepplestone Gardens
    AB15 4DH Aberdeen
    British109709500001
    LUDGATE NOMINEES LIMITED
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    900013890001
    LUDGATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    7 Pilgrim Street
    EC4V 6DR London
    900013900001

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Waldorf Production Uk Plc
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    England
    ৩০ জুন, ২০১৬
    St Peter's Square
    M2 3DE Manchester
    One
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland And Wales
    নিবন্ধিত স্থানRegistrar Of Companies Of England And Wales
    নিবন্ধন নম্বর05030838
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    WALDORF PRODUCTION NORTH SEA LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ২০১৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ২০১৯
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Glas Trust Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ অক্টো, ২০১৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other grantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All equipment, all inventory, all accounts, the initial pledged equity, all additional shares of stock, all indebtedness the securites accounts, the account collateral, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bnp Paribas (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৬ ফেব, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including the relevant project accounts, any present or future insurances together with all related property rights, the hedging agreements, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bnp Paribas (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the all property and assets present and future including the relevant project accounts, insurances, and the hedging agreements,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bnp Paribas (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in all equipment, all inventory, all accounts, the initial pledged equity, all additional shares, all indebtedness, all contracts, the account collateral, intellectual property collateral,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bnp Paribas (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    An omnibus letter of set-off
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge all of its rights to and title and interest from time to time in the whole of its property (including, for the avoidance of doubt, any insurance proceeds), assets, rights and revenues, whatsoever and wheresoever, present and future, including its uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Trustee for the Secured Creditors(The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১০ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargor or any obligor to the agent and the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and discharge all obligations and liabilities due or to become due from any obligor to the chargee as agent and trustee for itself, the other finance parties and the overdraft bank (the "agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The whole of its property assets rights and revenues whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and discharge all obligations and liabilities due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) or to the overdraft bank under or pursuant to the finance documents (or any of them) or the overdraft (all as defined therein)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its right title and interest in the whole of its property, assets, rights and revenues including its uncalled share capital. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited(As Agent and Trustee for Itself and for the Other Finance Parties and the Overdraft Bank ("Theagent") )
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0