ASMMC LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামASMMC LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03548695
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ASMMC LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7260) /

    ASMMC LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Mansion House
    Benham Valence
    RG20 8LU Newbury
    Berks
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ASMMC LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CSTIM LIMITED১৭ এপ্রি, ১৯৯৮১৭ এপ্রি, ১৯৯৮

    ASMMC LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    ASMMC LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    ২০ সেপ, ২০১১ তারিখে Simon Derek Burt-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১৭ মে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.04
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    স্মারকলিপি এবং/অথবা সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ২২ ফেব, ২০১১ তারিখে Terence William Burt-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    38 পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    10 পৃষ্ঠাMG01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAUD

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Agreements 19/07/2010
    RES13

    legacy

    30 পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    9 পৃষ্ঠাMG01

    পরিচালক হিসাবে Simon Derek Burt-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ জুন, ২০১০ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    সচিব হিসাবে Nicholas Paul Grossman-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে Terence William Burt-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Nicholas Paul Grossman-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Suzanne Chase এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ASMMC LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GROSSMAN, Nicholas Paul
    St. Margarets Road
    TW1 1PW Twickenham
    343
    Middlesex
    সচিব
    St. Margarets Road
    TW1 1PW Twickenham
    343
    Middlesex
    British152276380001
    BURT, Simon Derek
    Lansdowne Road
    BN11 4NA Worthing
    25
    England
    পরিচালক
    Lansdowne Road
    BN11 4NA Worthing
    25
    England
    EnglandBritishDirector115791650002
    BURT, Terence William
    One Wycombe Square
    W8 7JF London
    Flat 25
    United Kingdom
    পরিচালক
    One Wycombe Square
    W8 7JF London
    Flat 25
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director73890540004
    GROSSMAN, Nicholas Paul
    St. Margarets Road
    TW1 1PW Twickenham
    343
    Middlesex
    পরিচালক
    St. Margarets Road
    TW1 1PW Twickenham
    343
    Middlesex
    United KingdomBritishManager157544150001
    CAMERON, Lee John Harcourt
    58 Green Street
    WD3 5QR Chorleywood
    Hertfordshire
    সচিব
    58 Green Street
    WD3 5QR Chorleywood
    Hertfordshire
    British76251460003
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Heathfield Terrace
    W4 4JE Chiswick
    24
    United Kingdom
    সচিব
    Heathfield Terrace
    W4 4JE Chiswick
    24
    United Kingdom
    BritishSolicitor135246350002
    CHRISTOPHOROU, Steven Richard
    Adrian Road
    WD5 0AQ Abbots Langley
    12
    Hertfordshire
    Uk
    সচিব
    Adrian Road
    WD5 0AQ Abbots Langley
    12
    Hertfordshire
    Uk
    BritishSolicitor132483000001
    HARRIS, Karen
    36 Wayside Avenue
    Bushey
    WD23 4SQ Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    36 Wayside Avenue
    Bushey
    WD23 4SQ Watford
    Hertfordshire
    British40834090003
    SANDISON, Nicholas Andrew Macdonald
    1 Dawes Lane
    Sarratt
    WD3 6BA Rickmansworth
    Hertfordshire
    সচিব
    1 Dawes Lane
    Sarratt
    WD3 6BA Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishLawyer100721440002
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    LINDEMANN LINDSAY
    Suite 513 5th Floor Africa House
    64-78 Kingsway
    WC2B 6BG London
    কর্পোরেট সচিব
    Suite 513 5th Floor Africa House
    64-78 Kingsway
    WC2B 6BG London
    68688700001
    ALCOCK, Kevin Robert
    Derby Road
    GU27 1BP Haslemere
    Doyle House
    Surrey
    Uk
    পরিচালক
    Derby Road
    GU27 1BP Haslemere
    Doyle House
    Surrey
    Uk
    EnglandBritishConsultant135964000001
    BERESFORD, David Michael
    Otterbourne Road
    Compton
    SO21 2BB Winchester
    The Coach House
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Otterbourne Road
    Compton
    SO21 2BB Winchester
    The Coach House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director136196730001
    BOWER, David George Clifford
    Catsland Farmhouse
    Bramlands Lane
    BN5 9TG Woodmancote
    West Sussex
    পরিচালক
    Catsland Farmhouse
    Bramlands Lane
    BN5 9TG Woodmancote
    West Sussex
    BritishDirector120738860001
    BURTON, Alan Christopher
    The Coach House
    Marly Knowe, Windygates Road
    EH39 4QP North Berwick
    East Lothian
    পরিচালক
    The Coach House
    Marly Knowe, Windygates Road
    EH39 4QP North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritishRetired Co Director59221290001
    CHARLES, Jeremy Douglas
    29 Middleton Road
    NW11 7NR London
    পরিচালক
    29 Middleton Road
    NW11 7NR London
    EnglandBritishConsultant19690700002
    CONNOR, James Michael
    17d Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    17d Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    Surrey
    CanadianManagement Consultant79013050001
    CRUICKSHANK, Stuart
    13 Gloucester Road
    W5 4JB London
    পরিচালক
    13 Gloucester Road
    W5 4JB London
    EnglandBritishAccountant114599790001
    DALLAS, John Scott
    Zouches Farm
    Dunstable Road
    LU1 4AP Caddington
    The Grange
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Zouches Farm
    Dunstable Road
    LU1 4AP Caddington
    The Grange
    Bedfordshire
    United KingdomBritishConsultant122560090002
    DE NICOLA, Lionel Jules Rene
    Protea Heights
    Martingale Avenue
    Hout Bay
    7806
    South Africa
    পরিচালক
    Protea Heights
    Martingale Avenue
    Hout Bay
    7806
    South Africa
    FrenchConsultant68455510001
    DODD, Eric Stephen
    33 Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    33 Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Finance Director113939500001
    HARVEY, Terence
    Riddings Farm
    Hanbury Road, Anslow
    DE13 9QT Burton On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    Riddings Farm
    Hanbury Road, Anslow
    DE13 9QT Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector29863610002
    HAY, Douglas Stephen
    Mandalay
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    পরিচালক
    Mandalay
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    BritishInvestment Manager1223250004
    HOBBS, Martin Kenneth
    24 Elgin Crescent
    W11 2JR London
    পরিচালক
    24 Elgin Crescent
    W11 2JR London
    United KingdomSouth AfricanLawyer113652560001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director44173560008
    LUMER, Dean John
    8 Janmead
    Hutton
    CM13 2PU Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    8 Janmead
    Hutton
    CM13 2PU Brentwood
    Essex
    EnglandBritishDirector81310430001
    MCINTYRE, Duncan James
    Chesters
    Orchard Way
    KT10 9DY Esher
    Surrey
    পরিচালক
    Chesters
    Orchard Way
    KT10 9DY Esher
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director41795980002
    MILLWARD, Guy Leighton
    KT7
    পরিচালক
    KT7
    United KingdomBritishFinance Director203759730001
    PHILLIPS, Michael Scott
    Criafolen 13 Daneswood Close
    KT13 9AY Weybridge
    Surrey
    পরিচালক
    Criafolen 13 Daneswood Close
    KT13 9AY Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishGroup Finance Director59751680001
    ROBINSON, Boyd
    Flat 6
    57 Sinclair Road
    W14 0NR London
    পরিচালক
    Flat 6
    57 Sinclair Road
    W14 0NR London
    United KingdomBritishAccountant82244620001
    STEWART, Andrew Martin
    The Manor
    High Street
    MK16 9NB Sherington
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Manor
    High Street
    MK16 9NB Sherington
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector169598350001
    SUMMERS, Andrew John Sibbald
    27 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    পরিচালক
    27 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    BritishInvestment Manager42068840001
    WARD, Hugh Roderick
    Sunset Lodge
    La Rue De Haute
    JE3 8AR St Brelade
    Jersey
    পরিচালক
    Sunset Lodge
    La Rue De Haute
    JE3 8AR St Brelade
    Jersey
    JerseyBritishInvestment Company Executive89956550001
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001

    ASMMC LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A confirmatory debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ ফেব, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Bank of Canada Europe Limited (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৪ ফেব, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জানু, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জানু, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hutton Collins Capital Partners Iii
    ব্যবসায়
    • ১৪ জানু, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুল, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, credit balances, insurances and other contracts see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Bank of Canada Europe Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Secured Creditors (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুল, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hutton Collins Capital Partners Iii
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ মার্চ, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ ডিসে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £27,500.00.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    ব্যবসায়
    • ০৭ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed dated 29 july 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum deposit is £27,500.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0