INHEALTH (ACAD) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামINHEALTH (ACAD) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03558087
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    INHEALTH (ACAD) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • সাধারণ মেডিকেল প্র্যাকটিস কার্যক্রম (86210) / মানব স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কাজ কার্যক্রম

    INHEALTH (ACAD) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    INHEALTH (ACAD) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    IMPREGILO MEDICAL TECHNOLOGIES (ACAD) LIMITED২৮ জানু, ১৯৯৯২৮ জানু, ১৯৯৯
    IMPREGILO MEDICAL TECHNOLOGIES LIMITED৩০ জুল, ১৯৯৮৩০ জুল, ১৯৯৮
    IMPREGILO HEALTHCARE LIMITED৩০ জুন, ১৯৯৮৩০ জুন, ১৯৯৮
    FILBUK 525 LIMITED০৫ মে, ১৯৯৮০৫ মে, ১৯৯৮

    INHEALTH (ACAD) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১২

    INHEALTH (ACAD) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ জুন, ২০১৩

    ০৪ জুন, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    ৩০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Ms Sarah Louise Bricknell-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    ৩০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Bibi Rahima Ally এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ১৪ ডিসে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alice Sarah Louise Cummings-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ১৪ ডিসে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Helen Claire Lodge এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ নভে, ২০১১ তারিখে Sarah Louise Bricknell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Louise Julia Ballinger-Finch এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Philip Whitecross এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    ০১ মার্চ, ২০১০ তারিখে Helen Claire Lodge-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ মার্চ, ২০১০ তারিখে Philip James Whitecross-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ মার্চ, ২০১০ তারিখে Louise Julia Ballinger-Finch-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ মার্চ, ২০১০ তারিখে Sarah Louise Bricknell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    INHEALTH (ACAD) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRICKNELL, Sarah Louise
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    সচিব
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    169006310001
    BRICKNELL, Sarah Louise
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector And General Counsel124903930001
    CUMMINGS, Alice Sarah Louise
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director165558280001
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    সচিব
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    British38963210007
    CATRINI, Gianfranco
    Contrada Albereto
    Nicosia En
    94014
    Italy
    সচিব
    Contrada Albereto
    Nicosia En
    94014
    Italy
    ItalianAdministration Manager82872410001
    LOCATELLI, Luigi
    Impregilo Spa Viale Italia 1
    20099 Sesto San Giovanni
    FOREIGN Milan
    Italy
    সচিব
    Impregilo Spa Viale Italia 1
    20099 Sesto San Giovanni
    FOREIGN Milan
    Italy
    Italian71235150003
    FILBUK (SECRETARIES) LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004990001
    BAGNATI, Pietro
    15 Bearfort Court
    Admirals Landing
    CF1 5AH Cardiff
    পরিচালক
    15 Bearfort Court
    Admirals Landing
    CF1 5AH Cardiff
    ItalianEngineer40476800001
    BALLINGER-FINCH, Louise Julia
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishHr Director124865840001
    BARTLETT, Jeremy Ian
    22 The Hamlet
    Nailsea
    BS48 1BY Bristol
    পরিচালক
    22 The Hamlet
    Nailsea
    BS48 1BY Bristol
    BritishDirector97771060001
    BARTLETT, Jeremy Ian
    22 The Hamlet
    Nailsea
    BS48 1BY Bristol
    পরিচালক
    22 The Hamlet
    Nailsea
    BS48 1BY Bristol
    BritishGeneral Manager97771060001
    GIBSON, Alan James
    Chapel Farmhouse
    OX18 2RY Grafton
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Chapel Farmhouse
    OX18 2RY Grafton
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director77962110001
    JOYCE, Shaun William
    3 The View
    Alwoodley
    LS17 7NA Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    3 The View
    Alwoodley
    LS17 7NA Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinancial Director118023760001
    LOCATELLI, Luigi
    Impregilo Spa Viale Italia 1
    20099 Sesto San Giovanni
    FOREIGN Milan
    Italy
    পরিচালক
    Impregilo Spa Viale Italia 1
    20099 Sesto San Giovanni
    FOREIGN Milan
    Italy
    ItalianFinancial Manager71235150003
    LODGE, Helen Claire
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector133195230001
    MORELLO MOSTO, Cesare Arturo
    The Penthouse Osbourne House
    Clive Crescent
    CF64 1AT Penarth
    South Glamorgan
    পরিচালক
    The Penthouse Osbourne House
    Clive Crescent
    CF64 1AT Penarth
    South Glamorgan
    ItalianArea Manager67440740001
    TALOTTA, Roberto
    Viale Italia No 1
    Sesto S Giovanni
    FOREIGN Italy
    20099
    পরিচালক
    Viale Italia No 1
    Sesto S Giovanni
    FOREIGN Italy
    20099
    ItalianCivil Engineer83103910001
    WHITECROSS, Philip James
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Beechwood Hall
    Kingsmead Road
    HP11 1JL High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director193730760001
    ZANIN, Tiziano
    8 William Hunt Mansions
    4 Somerville Avenue
    SW13 8HS London
    পরিচালক
    8 William Hunt Mansions
    4 Somerville Avenue
    SW13 8HS London
    ItalianDirector94169380001
    FILBUK NOMINEES LIMITED
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Fitzalan House
    Fitzalan Road
    CF2 1XZ Cardiff
    South Glamorgan
    900004980001

    INHEALTH (ACAD) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Novation notice
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as impregilo medical technologies (acad) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title benefit and interest in the first 57% of each of the amounts paid, the loss of profits insurance policy. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Lease (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Novation notice
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as impregilo medical technologies (acad) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge all right title interest in all monies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Lease (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Novation notice
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as impregilo medical technologies (acad) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge all right title interest in all monies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Lease (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed supplemental to a fixed and floating charge of even date
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an equipment lease agreement dated 23RD march 1999,a direct agreement dated 23RD march 1999 and the fixed and floating charge of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge all right title interest in all monies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dvi Financial Services Inc
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of assignment of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an equipment lease agreement dated 23RD march 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title benefit and interest in the first 57% of each of the amounts paid,the loss of profits insurance policy. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dvi Financial Services Inc
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an equipment lease agreement dated 23RD march 1999,a direct agreement dated 23RD march 1999 and the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge all right title interest and benefit in all monies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dvi Financial Services Inc
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0