WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামWILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03576124
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    WILLIAM COOK BLAIR MACHINE SHOP LIMITED২৯ অক্টো, ১৯৯৮২৯ অক্টো, ১৯৯৮
    IMCO (1898) LIMITED০৪ জুন, ১৯৯৮০৪ জুন, ১৯৯৮

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৭ মার্চ, ২০১০

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    14 পৃষ্ঠা4.72

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন ০৫ আগ, ২০১১ তারিখে

    LRESEX

    ০৪ আগ, ২০১২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    5 পৃষ্ঠা4.20

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ জুন, ২০১১

    ০৭ জুন, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ২৭ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ২৮ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ২৯ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Re guarnatee / debenture & intercreditior deed 29/01/2008
    RES13

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    8 পৃষ্ঠা395

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ০১ এপ্রি, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    7 পৃষ্ঠা395

    পূর্ণ হিসাব ০২ এপ্রি, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HOUGHTON, Michael Barry
    8 The Old Saw Mill
    Cowling
    BD22 0JT Keighley
    West Yorkshire
    সচিব
    8 The Old Saw Mill
    Cowling
    BD22 0JT Keighley
    West Yorkshire
    British109567330001
    COOK, Andrew John, Sir
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    পরিচালক
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    EnglandBritish102659430002
    GRAYLEY, Kevin John
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish43273780002
    AUSTIN, John Alan
    1 Hollincross Lane
    SK13 8JQ Glossop
    Derbyshire
    সচিব
    1 Hollincross Lane
    SK13 8JQ Glossop
    Derbyshire
    British99402330001
    BARTLE, Thomas
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    সচিব
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    British79918800001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    সচিব
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British83552520001
    COOK, David Laurence
    30 Hargreaves Close
    Morley
    LS27 9TE Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    30 Hargreaves Close
    Morley
    LS27 9TE Leeds
    West Yorkshire
    British92183980001
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    সচিব
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    British43273740002
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    মনোনীত সচিব
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British900006640001
    BARTLE, Thomas
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    পরিচালক
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    British79918800001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish83552520001
    CLARK, Ross Mckenzie
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    মনোনীত পরিচালক
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    British900016690001
    DEAN, David James
    15 Tremaine Close
    Hartside
    TS27 3LE Hartlepool
    Teeside
    পরিচালক
    15 Tremaine Close
    Hartside
    TS27 3LE Hartlepool
    Teeside
    EnglandBritish90981030001
    KITE, Philip John
    Garden House Town Farm
    NE43 7UL Newton
    Northumberland
    পরিচালক
    Garden House Town Farm
    NE43 7UL Newton
    Northumberland
    United KingdomBritish43273920002
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    পরিচালক
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    British43273740002
    SIMKINS, Angela
    Hambleton View Kirby Hill
    Boroughbridge
    YO51 9DS York
    পরিচালক
    Hambleton View Kirby Hill
    Boroughbridge
    YO51 9DS York
    United KingdomBritish60263960001

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • William Cook Holdings Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Catton foundry cross green approach leeds t/n WYK458821, inkerman tow law county durham t/n DU169329, bond isle works stanhope durham t/n DU178165 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Trustees of the Aj Cook Pension Scheme
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the royal bank of scotland PLC and barclays bank PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ আগ, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of all or any group company to the chargee under or pursuant to any finance document under the terms of the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Andrew John Cook Cbe (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ২৬ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Dede of adherence (to a composite guanrantee and debenture date 23 january 1998)
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All indebtedness liabilities and payment obligations which are as at 30 october 1998 may at any time hereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever by any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৭ জানু, ২০১৪ভেঙে গেছে
    ০৫ আগ, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John Russell
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    অভ্যাসকারী
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Andrew Philip Wood
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    অভ্যাসকারী
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0