GHSD3 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGHSD3 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03576360
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GHSD3 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    GHSD3 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o SCHLEGEL UK (2006) LTD
    Unit 25 Henlow Industrial Estate
    SG16 6DS Henlow Camp
    Bedfordshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GHSD3 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HOMESAFE DOORS LIMITED২৫ আগ, ২০১০২৫ আগ, ২০১০
    INTRON LIMITED১১ আগ, ১৯৯৮১১ আগ, ১৯৯৮
    KELTOAST LIMITED০৫ জুন, ১৯৯৮০৫ জুন, ১৯৯৮

    GHSD3 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    GHSD3 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed homesafe doors LIMITED\certificate issued on 12/09/12
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ৩১ আগ, ২০১২

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ জুন, ২০১২

    ০৭ জুন, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 222,705
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ২৩ মার্চ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Francis O'connell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ মার্চ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Darren Andrew Waters-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৬ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Kevin Francis O'connell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৩ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Karl Pawson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৯ আগ, ২০১০

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Ian Karl Pawson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Paul Nugent এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Paul Nugent এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে John Ternent এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    GHSD3 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    JOHNSON, Simon
    c/o Schlegel Uk (2006) Limited
    Henlow Industrial Estate
    SG16 6DS Henlow Camp
    Unit 25
    Bedfordshire
    England
    সচিব
    c/o Schlegel Uk (2006) Limited
    Henlow Industrial Estate
    SG16 6DS Henlow Camp
    Unit 25
    Bedfordshire
    England
    149200840001
    SWAN, John Richard
    Stratford Close
    Toddington
    LU5 6BL Dunstable
    8
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Stratford Close
    Toddington
    LU5 6BL Dunstable
    8
    Bedfordshire
    United KingdomBritishAccountant70300400002
    WATERS, Darren Andrew
    Henlow Industrial Estate
    SG16 6DS Henlow
    Unit 25
    Bedfordshire
    England
    পরিচালক
    Henlow Industrial Estate
    SG16 6DS Henlow
    Unit 25
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishDirector130729200001
    LANGLEY, Derek Frederick
    Silver Birches
    Oaken Lanes
    WV8 2AW Codsall
    Wolverhampton
    সচিব
    Silver Birches
    Oaken Lanes
    WV8 2AW Codsall
    Wolverhampton
    BritishDirector59390600001
    LIGHTOWLERS, John
    3 Ribston Mews
    Stroud Road
    GL1 5EU Gloucester
    Gloucestershire
    সচিব
    3 Ribston Mews
    Stroud Road
    GL1 5EU Gloucester
    Gloucestershire
    BritishCompany Director111277770001
    TANNER, Rebecca Clare
    26 Victoria Road
    NN1 5ED Northampton
    Northamptonshire
    সচিব
    26 Victoria Road
    NN1 5ED Northampton
    Northamptonshire
    British58637650001
    TAYLOR, Mark
    19 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    সচিব
    19 Doran Close
    B63 1JZ Halesowen
    West Midlands
    BritishFinance Director109418300001
    TERNENT, John William
    30 Hazel Drive
    Wythall
    B47 5RJ Birmingham
    সচিব
    30 Hazel Drive
    Wythall
    B47 5RJ Birmingham
    BritishAccountant76813040002
    THORNE, Nigel Martyn
    Lock House Castle Meadow Road
    NG2 1AG Nottingham
    Nottinghamshire
    সচিব
    Lock House Castle Meadow Road
    NG2 1AG Nottingham
    Nottinghamshire
    British73834740002
    ADAMS, John William
    2 Northfield Cottages
    Withington Road
    GL54 4LL Andoversford
    Gloucestershire
    পরিচালক
    2 Northfield Cottages
    Withington Road
    GL54 4LL Andoversford
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector103575750001
    BEIM, Dusan David
    Longhill
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JN Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Longhill
    Duntisbourne Abbotts
    GL7 7JN Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector59387810002
    CONROY, Vincent
    Medway
    Chardstock
    EX13 7BN Axminster
    Devon
    পরিচালক
    Medway
    Chardstock
    EX13 7BN Axminster
    Devon
    BritishCompany Director107505230001
    DRABBLE, Geoffrey
    2 Sugar Hill Farm
    Stutton
    LS24 9NF Tadcaster
    North Yorkshire
    পরিচালক
    2 Sugar Hill Farm
    Stutton
    LS24 9NF Tadcaster
    North Yorkshire
    United KingdomBritishDirector48159930002
    HORNBY, Andrew Robert
    Brooklands
    Ripley Road
    HG5 9BY Knaresborough
    Yorkshire
    পরিচালক
    Brooklands
    Ripley Road
    HG5 9BY Knaresborough
    Yorkshire
    UkUkFinance Director87351320001
    HUNTER, Justin
    6 Towbury Court
    Kilmore Lane
    GL20 6EN Twyning
    Gloucestershire
    পরিচালক
    6 Towbury Court
    Kilmore Lane
    GL20 6EN Twyning
    Gloucestershire
    BritishCompany Director114241530001
    LANGLEY, Derek Frederick
    Silver Birches
    Oaken Lanes
    WV8 2AW Codsall
    Wolverhampton
    পরিচালক
    Silver Birches
    Oaken Lanes
    WV8 2AW Codsall
    Wolverhampton
    BritishDirector59390600001
    LEWINGTON, Keith Edward
    Ford Cottage 17 Milton Road
    Willen Village
    MK15 9AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    মনোনীত পরিচালক
    Ford Cottage 17 Milton Road
    Willen Village
    MK15 9AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British900004940001
    LIGHTOWLERS, John
    3 Ribston Mews
    Stroud Road
    GL1 5EU Gloucester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    3 Ribston Mews
    Stroud Road
    GL1 5EU Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director111277770001
    MASON, David Maurice
    206 London Road
    GL52 6HJ Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    206 London Road
    GL52 6HJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director5168370001
    NUGENT, Paul John
    Netherpaths
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    পরিচালক
    Netherpaths
    Colwall Green
    WR13 6DX Malvern
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector98013620002
    O'CONNELL, Kevin Francis
    Buckingham Gate
    SW1E 6AS London
    65
    England
    পরিচালক
    Buckingham Gate
    SW1E 6AS London
    65
    England
    EnglandIrishAccountant163807530001
    PAWSON, Ian Karl
    Henlow Industrial Estate
    SG16 6DS Henlow Camp
    Unit 25
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Henlow Industrial Estate
    SG16 6DS Henlow Camp
    Unit 25
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector124505380001
    PEPPIATT, Charles St John Stewart
    Barn Cottage
    21, Duntisbourne Leer
    GL7 7AS Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Barn Cottage
    21, Duntisbourne Leer
    GL7 7AS Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director105457130004

    GHSD3 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    An english security deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ সেপ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage of patents
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the patents and rights in inventions in patent no. GB2267529. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ জুল, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture (fixed and floating charge)
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to fixed rate loan notes 2010 issued on 10 july 1998
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Murray Johnstone Limited (As Trustee for the Lenders)
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ মে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0