TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03592155
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TRADER MEDIA CORPORATION LIMITED১৫ জুন, ২০০০১৫ জুন, ২০০০
    HURST CORPORATION LIMITED০৩ জুল, ১৯৯৮০৩ জুল, ১৯৯৮
    HURST NEWCO 4 LIMITED২৯ জুন, ১৯৯৮২৯ জুন, ১৯৯৮

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৯ মার্চ, ২০১৫

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    ১৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Trevor Nigel Mather এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ ফেব, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100.1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel share premium account 15/01/2016
    RES13

    চার্জ 035921550007 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    পূর্ণ হিসাব ২৯ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    9 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ মে, ২০১৫

    ২৮ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100.1
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01

    চার্জ নিবন্ধন 035921550007, ১৫ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    31 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ 035921550006 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ১৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে Mr Trevor Nigel Mather-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে Mr Sean Glithero-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ১৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে Mr Sean Robert Glithero-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৩ ডিসে, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Auto Trader House Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT থেকে 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FNপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩০ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    40 পৃষ্ঠাAA

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GLITHERO, Sean
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    সচিব
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    159906130001
    GLITHERO, Sean Robert
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    পরিচালক
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish129229070002
    SOMERSET, Ian
    M15 4FN Manchester
    Number 1 First Street
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    M15 4FN Manchester
    Number 1 First Street
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish191225040001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    সচিব
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    British15959630001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    সচিব
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    সচিব
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    JENKIN, Elizabeth
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    British137518870001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    সচিব
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    সচিব
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    সচিব
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    United Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    সচিব
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    পরিচালক
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United KingdomBritish147214630001
    CASTRO, Nicholas
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    পরিচালক
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    EnglandBritish39006500001
    COLLET, Tara
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish160951420001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    KING, John Robert
    Tresspassers
    Knowle Hill
    GU25 4HZ Virginia Water
    Surrey
    পরিচালক
    Tresspassers
    Knowle Hill
    GU25 4HZ Virginia Water
    Surrey
    Australian126634830001
    LANE, Stephen John Roger
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    EnglandBritish123670600001
    LUFF, Graham Ewart
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    British46555440002
    MATHER, Trevor Nigel
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    পরিচালক
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish83431330001
    MCCALL, Carolyn Julia
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    পরিচালক
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British39252480010
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    পরিচালক
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritish162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    EnglandUnited Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    STOREY, Graham Neil
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Treetops
    Garden Close Lane
    RG14 6PP Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish48939070004

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০১৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wilmington Trust (London) Limited and Its Successors in Title and Permitted Transferees
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৮ জানু, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Trademarks and domain names being trader media (words only) trader media group (words only) trader media group (image) 8 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wilmington Trust (London) Limited (and Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৫ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুল, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুল, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৫ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P.Morgan Europe Limtied as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ নভে, ২০০৯বিবৃতি যে সম্পত্তির একটি অংশ বা সমস্ত চার্জ মুক্তি পেয়েছে (MG04)
    • ২৫ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Global accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag London as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag London(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders)
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    TRADER MEDIA CORPORATION (2003) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৪ মার্চ, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২১ জানু, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    অভ্যাসকারী
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0