HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03627383
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Tong Hall
    Tong Lane
    BD4 0RR Bradford
    West Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    INTERACTIVITY GROUP PLC১৪ মে, ২০০১১৪ মে, ২০০১
    MYVAL.COM PLC০৫ নভে, ১৯৯৮০৫ নভে, ১৯৯৮
    OMEGA INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED০৭ সেপ, ১৯৯৮০৭ সেপ, ১৯৯৮

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০০৯

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    চূড়ান্ত অ্যাকাউন্টের নোটিশ দ্রবীভূত হওয়ার আগে

    21 পৃষ্ঠাWU15

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    19 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    18 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    18 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    18 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    18 পৃষ্ঠাWU07

    দেউলিয়া আবেদন

    INSOLVENCY:Progress report ends 14/08/2016
    14 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    দেউলিয়া আবেদন

    INSOLVENCY:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 14/08/2015
    8 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    পৃষ্ঠাCOCOMP

    একটি লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা4.31

    দেউলিয়া আবেদন

    INSOLVENCY:Liquidator's Progress Report :- 15/08/2013 - 14/08/2014
    9 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:liquidator's progress report :- 15/08/2012-14/08/2013
    9 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:annual report 15/08/11 to 14/08/12
    8 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:annual progress report - brought down date 14TH august 2012
    8 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    2 পৃষ্ঠাCOCOMP

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    একটি লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা4.31

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    1 পৃষ্ঠাCOCOMP

    পরিচালক হিসাবে John Honey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Goronwy Ffoulkes Davies এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Goronwy Ffoulkes Davies এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ১১ ডিসে, ২০০৯ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 9,964,192.192
    6 পৃষ্ঠাSH01

    ৩০ এপ্রি, ২০১০ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 9,964,192.192
    6 পৃষ্ঠাSH01

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GABORIT, Lyndon James
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    পরিচালক
    Lower Addison Gardens
    W14 8BG London
    25
    United KingdomAustralianFinance Director133660360001
    GUNN, John Humphrey
    23 Edwardes Square
    W8 6HE London
    পরিচালক
    23 Edwardes Square
    W8 6HE London
    EnglandBritishDirector705110002
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    সচিব
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishFinance Director54189670005
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    সচিব
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    British79348050002
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    সচিব
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    AustralianFinance Director65921870004
    GABORIT, Lyndon James
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    সচিব
    28 Welbeck Street
    W1G 8EW London
    AustralianFinance Director65921870004
    HYAMS, Anthony Harry
    102 Wolmer Gardens
    HA8 8QE Edgware
    Middlesex
    সচিব
    102 Wolmer Gardens
    HA8 8QE Edgware
    Middlesex
    British44815230001
    MACKAY, Thomas Alexander
    Lorton
    Toys Hill
    TN16 1QG Westerham
    Kent
    সচিব
    Lorton
    Toys Hill
    TN16 1QG Westerham
    Kent
    British44658840001
    SARGENT, Rodger David
    19 Chadwick Place
    St James Park Long Ditton
    KT6 5RE Surbiton
    সচিব
    19 Chadwick Place
    St James Park Long Ditton
    KT6 5RE Surbiton
    BritishDirector56891450002
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    AKERS, Chris
    22a Launceston Place
    W8 5RL London
    পরিচালক
    22a Launceston Place
    W8 5RL London
    BritishCompany Director77057180001
    BECKETT, Phillip
    6 Springfields
    HP6 5JU Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    6 Springfields
    HP6 5JU Amersham
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director70362260001
    BRADSHAW, John
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    200 Broadway
    PE1 4DT Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritishFinance Director54189670005
    BRIGGS, Michael
    Unit 1 1/2 Bramham Gardens
    South Kensington
    SW5 0JQ London
    পরিচালক
    Unit 1 1/2 Bramham Gardens
    South Kensington
    SW5 0JQ London
    AustralianCompany Director38666330001
    BRIGSTOCKE, Nicholas Owen
    St Anns
    Sheep Lane
    GU29 9NT Midhurst
    West Sussex
    পরিচালক
    St Anns
    Sheep Lane
    GU29 9NT Midhurst
    West Sussex
    EnglandBritishNon Executive Director98249500004
    BRUCK, Stuart
    416 31st Street
    Manhattan Beach
    FOREIGN Los Angeles
    California 90266
    United States
    পরিচালক
    416 31st Street
    Manhattan Beach
    FOREIGN Los Angeles
    California 90266
    United States
    AmericanExecutive Chairman88492530001
    DENOS, Kenneth
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    পরিচালক
    12694 South Rosburg Dr
    Riverton
    Utah 84065
    Usa
    AmericanAttorney93963450001
    FFOULKES DAVIES, Goronwy Philip
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    Crossfield House
    Aston By Budworth
    CW9 6NG Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishChartered Accountant79348050002
    HONEY, John Charles
    Greenways
    Lambourn
    RG17 7LH Hungerford
    Meridan House Std
    Berkshire
    পরিচালক
    Greenways
    Lambourn
    RG17 7LH Hungerford
    Meridan House Std
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director129122500001
    HUNTER, David James
    43a Church Lane
    Hornsey
    N8 7BT London
    পরিচালক
    43a Church Lane
    Hornsey
    N8 7BT London
    IrishCompany Director42626990001
    JONES, John Charles
    Villa Esterel 8 Avenue Victoria
    Le Cannet Alpes Maritimes
    FOREIGN France 06110
    পরিচালক
    Villa Esterel 8 Avenue Victoria
    Le Cannet Alpes Maritimes
    FOREIGN France 06110
    BritishEngineer60913620001
    KLEIN, Robin Matthew
    5 Upper Terrace
    Hampstead
    NW3 6RH London
    পরিচালক
    5 Upper Terrace
    Hampstead
    NW3 6RH London
    EnglandBritishCompany Director56477530001
    LAMEY, Richard
    11 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    পরিচালক
    11 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    BritishExecutive69447160001
    LOW, Michael Kingman
    6733 Abbottswood Drive
    Rancho Palos Verdes
    California 90275
    Usa
    পরিচালক
    6733 Abbottswood Drive
    Rancho Palos Verdes
    California 90275
    Usa
    UsaChief Operating Officer88429400001
    MAY, John Joseph
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    2 Belmont Way
    GU15 2BH Camberley
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director211557370001
    MCNAIR, Stewart Andrew
    5 The Links
    Burleigh Road
    SL5 7TN Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    5 The Links
    Burleigh Road
    SL5 7TN Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director42069020001
    MOORE, Anthony Roger
    7023 Pelican Island Drive
    FOREIGN Tampa
    Fl 33634
    Usa
    পরিচালক
    7023 Pelican Island Drive
    FOREIGN Tampa
    Fl 33634
    Usa
    British UsNon Executive Director88429330001
    PERSKE, Graham Anderson
    Flat 2-3
    23 Upperphillimore Gardens Kensingto
    W8 7HF London
    পরিচালক
    Flat 2-3
    23 Upperphillimore Gardens Kensingto
    W8 7HF London
    United KingdomAustralianCompany Director17802460001
    SARGENT, Rodger David
    19 Chadwick Place
    St James Park Long Ditton
    KT6 5RE Surbiton
    পরিচালক
    19 Chadwick Place
    St James Park Long Ditton
    KT6 5RE Surbiton
    BritishDirector56891450002
    SHEARER, Anthony Presley
    63a Holland Park
    W11 3SJ London
    পরিচালক
    63a Holland Park
    W11 3SJ London
    United KingdomBritishCompany Director115276930001
    STIMSON, Geoffrey George
    38 Tycehurst Hill
    IG10 1DA Loughton
    Essex
    পরিচালক
    38 Tycehurst Hill
    IG10 1DA Loughton
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director2201630001
    TOMPKINS, Henry John Mark
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    পরিচালক
    18 Thurloe Square
    SW7 2TE London
    EnglandBritishNon Executive Director109723760001
    WARNER, Rufus Andrew Douglas
    Cotchet Farm House
    Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    পরিচালক
    Cotchet Farm House
    Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director57560750002
    WOOD, Gordon Alexander
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    পরিচালক
    19th Street
    Manhattan Beach
    404
    Ca 90266
    Usa
    BritishDirector136141810001
    WRAY, Nigel William
    The Priory
    54 Totteridge Village
    N20 8PS London
    পরিচালক
    The Priory
    54 Totteridge Village
    N20 8PS London
    United KingdomBritishCompany Director45400750007

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over its undertaking all present and future assets together with all associated rights of any kind.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • John Humphrey Gunn (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 ordinary share of £1 fully paid in the capital of safa - ips healthcare limited company number 5173653. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জানু, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company declares that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank specified in the schedule to the memorandum. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Own account assignment of life policies
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The polices and all amounts taht are to be paid under it and any amount to be paid on cancellation of the policies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £27,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit of £27,500.00 made by the company with lloyds tsb bank PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Moonstone Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Charge over cash deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By clause 4 of the charge, the company charges to the bank the charged property, by clause 5, the company undertakes that it shall not create or allow to subsist any security interest over the charged property except for any permitted security interest;.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By clause 2 of the memorandum, the company declares that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank; clause 4, if at any time any further or other securities shall be deposited or transferred by the company to the bank or its trustees or nominees;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By clause 2 of the memorandum, the company declares that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank; clause 4, if at any time any further or other securities shall be deposited or transferred by the company to the bank or its trustees or nominees;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Charge over fluctuating deposits by the company, limited to £125,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Coutts & Company
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Hunter
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ মে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP PLC এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ৩০ মার্চ, ২০২২ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ০৮ জুন, ২০১১আবেদন তারিখ
    ২০ জুল, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৬ জুল, ২০২২ভেঙে গেছে
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    অভ্যাসকারী
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    The Official Receiver Or Chester
    The Official Receiver
    Suite5, 3rd Floor
    CH1 1DF Windsor House
    Pepper Street Chester
    অভ্যাসকারী
    The Official Receiver
    Suite5, 3rd Floor
    CH1 1DF Windsor House
    Pepper Street Chester
    Michael Field
    Tong Hall
    BD4 0RR Tong
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Tong Hall
    BD4 0RR Tong
    West Yorkshire
    Paul Howard Finn
    Tong Hall
    BD4 0RR Tong
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Tong Hall
    BD4 0RR Tong
    West Yorkshire
    James David Robinson
    Finn Associates Tong Hall
    Tong
    BD4 0RR Bradford
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Finn Associates Tong Hall
    Tong
    BD4 0RR Bradford
    West Yorkshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0