OPAL HULME LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOPAL HULME LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03636374
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OPAL HULME LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের রিয়েল এস্টেট ভাড়া এবং পরিচালনা (68201) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    OPAL HULME LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2 St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OPAL HULME LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SAVELINE LIMITED২২ সেপ, ১৯৯৮২২ সেপ, ১৯৯৮

    OPAL HULME LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১২

    OPAL HULME LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    চূড়ান্ত অ্যাকাউন্টের নোটিশ দ্রবীভূত হওয়ার আগে

    47 পৃষ্ঠাWU15

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    47 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    45 পৃষ্ঠাWU07

    উইন্ডিং আপের অগ্রগতির প্রতিবেদন আদালত কর্তৃক

    44 পৃষ্ঠাWU07

    ১১ আগ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Ernst & Young Llp 100 Barbirolli Square Manchester M2 3EY থেকে 2 st Peter's Square Manchester M2 3EYপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:progress report brought down to 24/06/16 resignation of t a jack
    42 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:liquidators annual progress report to 24/02/2016
    41 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    দেউলিয়া আবেদন

    Insolvency:liquidator's annual progress report - compulsory liquidation - b/d date - 24/02/2015
    42 পৃষ্ঠাLIQ MISC

    একটি লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা4.31

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    3 পৃষ্ঠাCOCOMP

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    4 পৃষ্ঠাCOCOMP

    প্রশাসনের সমাপ্তির আদালতের আদেশের নোটিশ

    54 পৃষ্ঠা2.33B

    ৩১ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    46 পৃষ্ঠা2.24B

    ১১ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    62 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠাF2.18

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    117 পৃষ্ঠা2.17B

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    5 পৃষ্ঠা2.16B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ অক্টো, ২০১২

    ১০ অক্টো, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    OPAL HULME LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    সচিব
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    পরিচালক
    St Peter's Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    OPAL HULME LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Oxford court stertford road hulme manchester t/no gm 801268. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land on the south side of stretford road, hulme (k/a oxford court) t/no. GM801268 and l/h land being briarfields boundary lane, hulme t/no. GM826100. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Securitytrustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold property k/a site 9 stretford road hulme manchester t/n GM801268 and leasehold property k/a briarfields boundary lane hulme manchester t/n GM826400 together with the gross rents licence fees and other monies the benefit of all guarantees and any agreements any and all insurance policies and the goodwill of any business. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All estate interest or right whatsoever of the mortgagor in an agreement dated 10TH december 1999 between the company and watkin jones & sons limited by whichg the contractor agreed to carry out consytruct and complete certain works at the site at briarfield boundary lane hulme.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property known as briarfields boundary lane hulme city of manchester; the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property site 9 stretford road hulme manchester together with goodwill of any business at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ২৪ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ আগ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    OPAL HULME LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১২ মার্চ, ২০১৩প্রশাসন শুরু
    ২৫ ফেব, ২০১৪প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    অভ্যাসকারী
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    2
    তারিখপ্রকার
    ১৩ সেপ, ২০১৯ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ১০ ফেব, ২০১৪আবেদন তারিখ
    ২৫ ফেব, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৯ ফেব, ২০২০ভেঙে গেছে
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Alan Robert Bloom
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samuel James Woodward
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    অভ্যাসকারী
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    The Official Receiver Or Manchester
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester
    অভ্যাসকারী
    2nd Floor, 3 Piccadilly Place
    London Road
    M1 3BN Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0