CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03712018
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (6603) /

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Yorkshire House
    18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    Merseyside
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CBS INSURANCE HOLDINGS PLC২৪ মার্চ, ১৯৯৯২৪ মার্চ, ১৯৯৯
    FORECASTWIN PUBLIC LIMITED COMPANY১১ ফেব, ১৯৯৯১১ ফেব, ১৯৯৯

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    7 পৃষ্ঠা4.71

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৫ ফেব, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৫ ফেব, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    32 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    18 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ মার্চ, ২০১১

    ০৩ মার্চ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,593.86
    SH01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    36 পৃষ্ঠাAA

    ১৮ আগ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,559.3855
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduce share prem 14/07/2010
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি। শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা পরিবর্তন হয়েছে

    22 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    22 পৃষ্ঠাAR01

    কোম্পানি গ্রুপের হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    35 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    13 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-MDSC

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduction of share premium account 17/12/2008
    RES13

    পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি থেকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পুনঃ নিবন্ধনের শংসাপত্র

    1 পৃষ্ঠাCERT10

    পুনঃনিবন্ধন সমিতির এবং সংবিধির নথি

    48 পৃষ্ঠাMAR

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    FOX, Andrew Staley
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    সচিব
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    British43073160004
    EWART, David John
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    পরিচালক
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish23635320001
    HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    পরিচালক
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    United KingdomBritish56874210004
    CRAWFORD SMITH, Neil Leslie
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    সচিব
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    British97197960001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    সচিব
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    MCMULLEN, Gerald Phipps
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    সচিব
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    British19668600001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CASTELL, Andrew Sean
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    পরিচালক
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    British85990150001
    FABER, Robin Henry Grey
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    পরিচালক
    Kingsmead House
    Didmarton
    GL9 1DT Badminton
    South Gloucestershire
    EnglandBritish104985010001
    HILL, Jeremy Grahame
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    পরিচালক
    Orwell Cottage
    School Hill, Nacton
    IP10 0EH Ipswich
    Suffolk
    British69062000004
    HOLBECH, Timothy Hugh
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    পরিচালক
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    British19390190001
    LEE, Michael Alan
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    পরিচালক
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Australian92794500001
    MCCLEAN, Michael Hugh Patrick
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    পরিচালক
    33b Cornwall Crescent
    W11 1PJ London
    British57912890001
    ROYDS, Emma Louise
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    পরিচালক
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    British30320080003
    SPARROW, Andrew James
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    পরিচালক
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish19390170004
    WATSON, Michael John Bannatyne
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    পরিচালক
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    British64292610002
    WHITE, Graham John
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish116735630001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the trustee or any of the other beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ২৫ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Share charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all right title and interest in and to the shares all dividends interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ অক্টো, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares, all dividends, interest and other moneys payable in respect of the shares; and all monetary claims and all related rights. Assignment of the proceeds of any insurance policy and all related rights; and all rights and claims in relation to any assigned account. First floating charge over the whole of the company's undertaking and assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Society Incorporated by Lloyd's Act 1871
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জানু, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ নভে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৮ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CBS INSURANCE HOLDINGS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৪ মার্চ, ২০১৩ভেঙে গেছে
    ১৫ ফেব, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Paul J Fleming
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool
    অভ্যাসকারী
    Yorkshire House 18 Chapel Street
    L3 9AG Liverpool

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0