FOOD PARTNERS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামFOOD PARTNERS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03804549
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    FOOD PARTNERS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    FOOD PARTNERS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    FOOD PARTNERS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DMWSL 270 LIMITED০৯ জুল, ১৯৯৯০৯ জুল, ১৯৯৯

    FOOD PARTNERS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৮

    FOOD PARTNERS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০৩ জুন, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Martin Johnson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৪ জুন, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Diarmuid Brendan Conifrey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৮ এপ্রি, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Diarmuid Brendan Conifrey-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    আদালতের আদেশ

    S1096 Court Order to Rectify
    6 পৃষ্ঠাOC

    ৩০ আগ, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 11 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    legacy

    পৃষ্ঠাANNOTATION

    ৩০ আগ, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    23 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    legacy

    47 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ মার্চ, ২০১৭ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ৩০ আগ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    31 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ আগ, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    ২৭ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Ian Tentori এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Gavin Cox এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gavin Eliot Cox এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Martin Johnson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৬ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Mark Ian Tentori-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    FOOD PARTNERS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    সচিব
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756650001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    সচিব
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500050001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    সচিব
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    BritishChartered Accountant48323870001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    সচিব
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British71735980002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    CHREE, Ian Charles Gordon
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    পরিচালক
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director65127980003
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    পরিচালক
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrishChief Finance Officer268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    পরিচালক
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritishDirector153840250001
    EARL, Elizabeth Jane
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director202375770001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    পরিচালক
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director83660790002
    HULBERT, David John
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishOperational And Technical Dire136463020001
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    পরিচালক
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishDirector140167360001
    KILSHAW, David Charles
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    পরিচালক
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    United KingdomBritishIndustrial Manager18455470002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    পরিচালক
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector157009150001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    পরিচালক
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    পরিচালক
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    BritishCompany Director96978470001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    পরিচালক
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    United KingdomBritishChartered Accountant48323870001
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    পরিচালক
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    BritishCompany Director63448390001
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    পরিচালক
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishChief Finance Officer119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    পরিচালক
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector63844650001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director71735980002
    THORPE, Alan
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    পরিচালক
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    BritishDistribution Manager81775420001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    পরিচালক
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector37845970003
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    পরিচালক
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector232132390001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    কর্পোরেট পরিচালক
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    FOOD PARTNERS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Adelie Foods Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    না
    আইনি ফর্মAdelie Foods Group Limited
    নিবন্ধিত দেশEngalnd & Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানRegistrar Of Companies
    নিবন্ধন নম্বর07964277
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    FOOD PARTNERS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ২০১৫
    বকেয়া
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    None.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১১ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to food partners limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of food partners limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১০ মার্চ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Punjab National Bank (International) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৬ ফেব, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৭ জুন, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    ব্যবসায়
    • ১৪ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৭ জুন, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £56,000 due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit amount see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Trw Pensions Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £18,066.80 due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit amount see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Trw Pensions Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies standing to the credit of the deposit account see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Brixton (Unit 6 Horton Road Poyle) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £43,505.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £43,505.00 or the amount of the credit in the account from time to time.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Microsoft Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ মার্চ, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Premium of £56,000 plus vat deposited by the company with the chargee and all other sums from time to time.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Trw Pensions Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each member of the group to the security agent and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ১৩ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 may 2006 and
    তৈরি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other security parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Rowallan business park, southcraig avenue, kilmarnock t/no. AYR3588.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Security Parties)
    ব্যবসায়
    • ২৭ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Share pledge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any additional shares and related rights, additional shares means any shares in the company including any such shares comprised in related rights meaning all dividends, interest. The comapany and the existing shares being food partners kilmarnock limited reg no:SC140577, ordinary shares of £1. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland 'Security Agent'
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ জুন, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26TH september 2005 and
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a rowallan business park, kilmarnock.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৭ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £62,500 or such greater sum as is equal to one half of the current annual rental as defined in the lease.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cockspur Property (General Partner) Limited and Cockspur Property (Nominee No.1) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Composite corporate guarantee
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    To exercise a right of set-off or retention in respect of all money at any time standing to the credit of the guarantor's accounts whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৭ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ নভে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0