HMTF POULTRY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHMTF POULTRY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03808291
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HMTF POULTRY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    HMTF POULTRY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HMTF POULTRY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    HMTF POULTRY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ সেপ, ২০১৩

    ১৬ সেপ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,015,528
    SH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ২০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Emmett Mcevoy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ এপ্রি, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Antony David Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৫ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Mcdonald-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৫ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Suzanne Elizabeth Wise এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    কোম্পানির আর্টিকেলগুলিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCC02

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    34 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ জুল, ২০১১ তারিখে Mr Simon Nicholas Wilbraham-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Antony David Smith-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Peeler এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Simon Nicholas Wilbraham-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Michael Peeler-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Ms Suzanne Elizabeth Wise-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Gwynfor Tyley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Paul Leach এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    HMTF POULTRY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneral Counsel & Company Secretary164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary125719290002
    BAMFORD, Philip Ian
    High Leys
    Danesbower Lane Blofield
    NR13 4LP Norwich
    Norfolk
    সচিব
    High Leys
    Danesbower Lane Blofield
    NR13 4LP Norwich
    Norfolk
    British4386590001
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    সচিব
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant58191970001
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    সচিব
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    KRAUSE, James Anthony
    70 Blackman Road
    Ridgefield
    FOREIGN Connecticut 06877
    Usa
    সচিব
    70 Blackman Road
    Ridgefield
    FOREIGN Connecticut 06877
    Usa
    AmericanDirector67276210001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    মনোনীত সচিব
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    ALEXANDER, Stephen Harold
    40 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    পরিচালক
    40 Thurleigh Road
    SW12 8UD London
    BritishDirector9796990001
    BUCHANAN, Keith Michael
    The Seedlings
    Bridge Road
    PE12 9EQ Long Sutton
    Lincolnshire
    পরিচালক
    The Seedlings
    Bridge Road
    PE12 9EQ Long Sutton
    Lincolnshire
    BritishCompany Director6017680002
    CAMPBELL, Rosalind Ilona
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    6 Hawthorn Close
    WD17 4SB Watford
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant58191970001
    KRAUSE, James Anthony
    70 Blackman Road
    Ridgefield
    FOREIGN Connecticut 06877
    Usa
    পরিচালক
    70 Blackman Road
    Ridgefield
    FOREIGN Connecticut 06877
    Usa
    AmericanDirector67276210001
    LEA, Lyndon
    38 Trevor Square
    SW7 1DY London
    পরিচালক
    38 Trevor Square
    SW7 1DY London
    CanadianInvester121737610001
    LEACH, Paul Alan
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasurer136797430001
    METROPOULOS, Charles Dean
    200 Crescent Court
    Suite 1600 Dallas
    75201 Texas
    Usa
    পরিচালক
    200 Crescent Court
    Suite 1600 Dallas
    75201 Texas
    Usa
    Greek AmericanChief Executive Officer67436310001
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant87359710001
    ROSEN, Andrew Scott
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    পরিচালক
    301 West 53rd Street
    New York
    Ny 10019
    United States
    AmericanCompany Director64268220001
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director147725160001
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    মনোনীত পরিচালক
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001
    TYLEY, Gwynfor Paul
    12 Prospect Road
    AL1 2AX St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    12 Prospect Road
    AL1 2AX St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant66169120001
    WISE, Suzanne Elizabeth
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishGeneral Counsel & Company Secretary136781050001

    HMTF POULTRY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property at glenthorn farm whittlesey road march cambridge t/no CB231846, f/h land and buildings on the east and west sides of marriott way melton constable t/nos NK243931 & NK239582, f/h land on the north west side of fenton way slade end chatteris and land lying to the north east of A142 chatteris and land lying to the east of the A141 chatteris t/nos CB207119, CB198960 and CB198959. For details of further properties charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture as supplemented and amended by a supplemental debenture dated 19 august 1999 issued by the company
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or each obligor company (as defined) to the chargee and/or the finance parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuantto the Facilities Agreement
    ব্যবসায়
    • ২৬ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0