OP REALISATIONS (NHL) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOP REALISATIONS (NHL) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03864086
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OP REALISATIONS (NHL) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    OP REALISATIONS (NHL) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OP REALISATIONS (NHL) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NOBLE HOUSE LEISURE LIMITED২৩ মে, ২০০০২৩ মে, ২০০০
    NOBLE HEALTH LEISURE LIMITED২৫ অক্টো, ১৯৯৯২৫ অক্টো, ১৯৯৯
    HAMSARD 2091 LIMITED২৫ অক্টো, ১৯৯৯২৫ অক্টো, ১৯৯৯

    OP REALISATIONS (NHL) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৭

    OP REALISATIONS (NHL) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২৯ সেপ, ২০১১ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    31 পৃষ্ঠা2.35B

    ২৩ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    31 পৃষ্ঠা2.24B

    ১২ জুন, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    31 পৃষ্ঠা2.24B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ৩১ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    30 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রতিস্থাপন/অতিরিক্ত প্রশাসক নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠা2.40B

    প্রশাসক কর্তৃক পদত্যাগের বিজ্ঞপ্তি

    12 পৃষ্ঠা2.39B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১২ জুন, ২০১০ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    27 পৃষ্ঠা2.24B

    ৩১ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    33 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১২ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    28 পৃষ্ঠা2.24B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    35 পৃষ্ঠাMA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    6 পৃষ্ঠা2.16B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    26 পৃষ্ঠা2.17B

    legacy

    2 পৃষ্ঠা88(2)

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed noble house leisure LIMITED\certificate issued on 10/02/09
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Amendment to deeds 24/09/2008
    RES13

    ব্যবসায়িক অবস্থার বিবরণ

    3 পৃষ্ঠাSA

    OP REALISATIONS (NHL) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director67008750001
    HALL, Jonathan Rufus
    47 Crouch Hall Lane
    Redbourn
    AL3 7EU St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    47 Crouch Hall Lane
    Redbourn
    AL3 7EU St. Albans
    Hertfordshire
    UkBritishChief Executive109659060001
    CLARKE, Stephen Paul
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    সচিব
    125 South Park Road
    Wimbledon
    SW19 8RX London
    British83058420001
    MURRAY, Alan John
    2 Brierley Road
    The Oakalls
    B60 2TE Bromsgrove
    Worcestershire
    সচিব
    2 Brierley Road
    The Oakalls
    B60 2TE Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishFinancial Controller104826920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008750001
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    কর্পোরেট সচিব
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    BENNETT, Stewart
    23 Dault Road
    SW18 2NH London
    পরিচালক
    23 Dault Road
    SW18 2NH London
    BritishVenture Capital76736200001
    BERNSTEIN, David Alan
    48 Fitzalan Road
    Finchley
    N3 3PE London
    পরিচালক
    48 Fitzalan Road
    Finchley
    N3 3PE London
    United KingdomBritishCo Director87832960001
    BLACK, Robin Kennedy
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    পরিচালক
    Nevergood Farmhouse
    Brick Kiln Lane
    TN12 8ES Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishFund Manager37965380001
    BONELLA, Richard John Murray
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Rose House
    Portsmouth Road Ripley
    GU23 6ER Woking
    Surrey
    BritishDirector33446940002
    BREARE, Robert Roddick Ackrill
    The Cottage
    Pink Lane
    SN16 9DS Charlton
    Wiltshire
    পরিচালক
    The Cottage
    Pink Lane
    SN16 9DS Charlton
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector38255700008
    CAHILL, John Patrick
    1 Wentworth Cottages
    Thorndown Lane
    GU20 6DJ Windlesham
    Surrey
    পরিচালক
    1 Wentworth Cottages
    Thorndown Lane
    GU20 6DJ Windlesham
    Surrey
    BritishGroup Operations Director63753920001
    CAMERON, John Douglas
    44 Erpingham Road
    Putney
    SW15 1BG London
    পরিচালক
    44 Erpingham Road
    Putney
    SW15 1BG London
    United KingdomBritishCompany Director73541250001
    CARSON, Anthony John
    22 Rose Walk
    The Webb Estate
    CR8 3LG Purley
    Surrey
    পরিচালক
    22 Rose Walk
    The Webb Estate
    CR8 3LG Purley
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director48536040006
    HAINING, Andrew
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    পরিচালক
    21 Stratford Grove
    SW15 1NU London
    BritishManaging Director42196640008
    HALL, Jonathan Rufus
    47 Crouch Hall Lane
    Redbourn
    AL3 7EU St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    47 Crouch Hall Lane
    Redbourn
    AL3 7EU St. Albans
    Hertfordshire
    UkBritishChief Executive109659060001
    JOHNSON, Ian Paul
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector76187110001
    KELLY, Michael Andrew John
    Camswell
    Carlton Road
    RH9 8LD South Godstone
    Surrey
    পরিচালক
    Camswell
    Carlton Road
    RH9 8LD South Godstone
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director55459180001
    SEYMOUR, Robert John
    70 Forest Road
    TW9 3BZ Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    70 Forest Road
    TW9 3BZ Richmond
    Surrey
    BritishInvestment Banker70955680001
    SHADBOLT, Marcus John
    Flat 6 154 Gloucester Terrace
    Paddington
    W2 6HR London
    পরিচালক
    Flat 6 154 Gloucester Terrace
    Paddington
    W2 6HR London
    BritishFund Manager75486820002
    UPTON, Christopher George
    Little Heath
    Kent Hatch Road, Limpsfield Chart
    RH8 0SZ Oxted
    Surrey
    পরিচালক
    Little Heath
    Kent Hatch Road, Limpsfield Chart
    RH8 0SZ Oxted
    Surrey
    EnglandBritishDirector103753080001
    HAMMOND SUDDARDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008740001

    OP REALISATIONS (NHL) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Properties k/a brb hampstead 48 rosslynhill london t/no NGL866531 green man green man lane hatton bedfont t/no AGL128345 railway hotel 390 oldfield lane greenford t/no AGL133528 (for details of further properties charged please refer to th. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any charging company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    ব্যবসায়
    • ২১ জুন, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge over all securities and all crest rights (as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit (as defined) as a continuing security for the discharge of the company's obligations. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge of securities
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over any stocks bonds warrants or securities. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    OP REALISATIONS (NHL) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৩ ডিসে, ২০০৮প্রশাসন শুরু
    ২৯ সেপ, ২০১১প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Colin Michael Trevethyn Haig
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court 3rd Floor
    EC4A 4HT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court 3rd Floor
    EC4A 4HT London
    David Christian Chubb
    Pricewaterhousecoopers Llp Richmond Hill
    BH2 6HR Bournemouth
    Dorset
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp Richmond Hill
    BH2 6HR Bournemouth
    Dorset
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Russell Downs
    Pricewaterhousecoopers Llp Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0