GORDON'S CHEMIST LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGORDON'S CHEMIST LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03865851
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GORDON'S CHEMIST LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    GORDON'S CHEMIST LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GORDON'S CHEMIST LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LEADINGTALK LIMITED২৬ অক্টো, ১৯৯৯২৬ অক্টো, ১৯৯৯

    GORDON'S CHEMIST LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০১৫

    GORDON'S CHEMIST LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    ২৪ জুন, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Francis Muller এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৪ জুন, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Jonathan Paul Wass-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ জুন, ২০১৬

    ০৭ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ অক্টো, ২০১৫

    ২৮ অক্টো, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    ০২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Andrew Richard Thompson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Richard Thompson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Charles Geoffrey Foster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে David Charles Geoffrey Foster এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ মার্চ, ২০১৫ থেকে ৩১ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ নভে, ২০১৪

    ০৪ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ নভে, ২০১৩

    ০৪ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৬ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Christopher Giles এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Mark Francis Muller-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    GORDON'S CHEMIST LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    THOMPSON, Andrew Richard
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    সচিব
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    201554790001
    THOMPSON, Andrew Richard
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    পরিচালক
    The Heights
    Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    2
    Surrey
    England
    EnglandBritish156945340001
    WASS, Jonathan Paul
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    England
    পরিচালক
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    England
    EnglandBritish209546930001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    সচিব
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150401600001
    GORDON, Joanne Helen
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    British67149540002
    HOLLIDAY, Alexander
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    সচিব
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    British40938150003
    HOLLIDAY, Anne Elizabeth
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    সচিব
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British40938220004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    সচিব
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    British63620010002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    AYLWARD, Christopher David
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    পরিচালক
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish59741430002
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    পরিচালক
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    পরিচালক
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish149729660001
    GORDON, Joanne Helen
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    19 Creskeld Drive
    LS16 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    British67149540002
    GORDON, Richard Michael
    19 Creskeld Drive
    LS19 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    19 Creskeld Drive
    LS19 9EJ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish67149480002
    HOLLIDAY, Alexander
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    British40938150003
    HOLLIDAY, Anne Elizabeth
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    Apperley House
    Milbourne Ponteland
    NE20 0JG Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British40938220004
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    পরিচালক
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritish110727230002
    MCCLINGTOCK, Jonathan Philip
    10 The Fellside
    NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    10 The Fellside
    NE3 4LJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British124559980001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    পরিচালক
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritish63620010002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    পরিচালক
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish63620010002
    PATEL, Anant Vinod
    264 Burley Road
    LS4 2NY Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    264 Burley Road
    LS4 2NY Leeds
    West Yorkshire
    British126533340001
    PILSBURY, Roger Graham
    222 Western Way
    NE20 9ND Ponteland
    Northumberland
    পরিচালক
    222 Western Way
    NE20 9ND Ponteland
    Northumberland
    United KingdomBritish181627090001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    GORDON'S CHEMIST LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ সেপ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge the undertaking and all property and assets including l/h properties k/a 7 quarry hill oulton leeds west yorkshire, 49 selby road leeds west yorkshire, rothwell health centre stonebridge lane rothwell leeds west yorkshire and 91 moresdale lane leeds west yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargees on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Stonebrig lane leeds,91 moorsdale lane leeds,7 quarry hill leeds,49 selby road leeds and all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time on such property and or the proceeds of sale thereof a floating equitable charge on all future f/h and l/h property a fixed charge on the goodwill and uncalled capital all book and other debts floating charge on the undertaking and all property and assets of the company both present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Aah Pharmaceuticals Limited and Barclay Pharmaceutical Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 49 selby road leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property known as 7 quarry hill oulton leeds west yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold property forming the pharmacy at rothwell health centre stone brig lane rothwell leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold property k/a 91 moredale lane leeds (k/a chemist shop seacroft south one stop centre foundry lane leeds west yorkshire t/n WYK670268. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold property k/a 49 selby road leeds west yorkshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0