SHELFCO 150502 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSHELFCO 150502 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03871224
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SHELFCO 150502 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    SHELFCO 150502 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o BRUNTWOOD LIMITED
    York House
    York Street
    M2 3BB Manchester
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SHELFCO 150502 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HILSTONE (SALE) LIMITED০৯ নভে, ১৯৯৯০৯ নভে, ১৯৯৯
    LIMPFOLD LIMITED০৪ নভে, ১৯৯৯০৪ নভে, ১৯৯৯

    SHELFCO 150502 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৪

    SHELFCO 150502 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    SHELFCO 150502 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৭ জুন, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Bruntwood Limited City Tower Piccadilly Plaza Manchester M1 4BT থেকে C/O Bruntwood Limited York House York Street Manchester M2 3BBপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ এপ্রি, ২০১৬

    ১২ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ এপ্রি, ২০১৫

    ০৯ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৮ এপ্রি, ২০১৪

    ০৮ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ২৮ জুন, ২০১৩ তারিখে Mr Kevin James Crotty-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr Kevin James Crotty-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    ১৫ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Christopher George Oglesby-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৫ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Mr Michael John Oglesby-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Christopher George Oglesby-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Mr Michael John Oglesby-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ৩০ মার্চ, ২০১০ তারিখে Katharine Jane Vokes-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    SHELFCO 150502 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    VOKES, Katharine Jane
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    সচিব
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    BritishCompany Director96739300002
    CROTTY, Kevin James
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    পরিচালক
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant117797270004
    OGLESBY, Christopher George
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    পরিচালক
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director53530470002
    OGLESBY, Michael John
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    পরিচালক
    c/o Bruntwood Limited
    York Street
    M2 3BB Manchester
    York House
    England
    United KingdomBritishCompany Director148307320001
    BROOKES, Alan Marcus
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    সচিব
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    BritishCompany Director2066880001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    সচিব
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    BritishAccountant2582690002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BOKENHAM, Michael Clifton Thomas
    South Park Lodge Carlton Road
    South Godstone
    RH9 8LD Godstone
    Surrey
    পরিচালক
    South Park Lodge Carlton Road
    South Godstone
    RH9 8LD Godstone
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor11496510001
    BROOKES, Alan Marcus
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    পরিচালক
    Exton Lodge
    Exton
    EX3 0PJ Exeter
    Devon
    EnglandBritishCompany Director2066880001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    SHELFCO 150502 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    B2000 borrower security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Borrower Security Trustee) (Whether from Its Own Account Oras Trustee for the Borrower Secured Creditors)
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Second third party legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from bruntwood estates limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fairbairn house, ashton lane, sale t/no. GM751420. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N M Rothschild & Sons Limited (As Security Trustee for the Finance Parties)
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First third party legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from bruntwood 2000 third properties limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fairbairn house, ashton lane, sale t/no. GM751420. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N M Rothschild & Sons Limited (As Security Trustee for the Finance Parties)
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage all estates or interests in the legally mortgaged property; by way of fixed charge all plant machinery vehicles computers and office and other equipment legally and beneficially owned by the chargor both present and future; all book and other debts goodwill and uncalled capital; by way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nationwide Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৩ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge by way of legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ নভে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee hilstone asset management limited and its subsidiaries in accordance with the terms of a loan agreement dated 4TH november 1999 as amended by a supplemental loan agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a fairbairn house ashton lane sale cheshire t/no: GM751420.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Century Life PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ নভে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0