DALERI LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDALERI LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03904536
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DALERI LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5245) /

    DALERI LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Zolfo Cooper Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DALERI LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    UNIQUE DISTRIBUTION LIMITED১১ জানু, ২০০০১১ জানু, ২০০০

    DALERI LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ এপ্রি, ২০০৪

    DALERI LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২৬ আগ, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    5 পৃষ্ঠা4.72

    ০১ জুন, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    ০১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    ০১ জুন, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠা4.68

    ০১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    দ্রবণ কমিটির সংবিধানের নোটিশ

    2 পৃষ্ঠা4.48

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    ০১ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ০১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ০১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    বিবিধ

    C/O replacement of liquidator
    4 পৃষ্ঠাMISC

    স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেটর হিসাবে কাজ বন্ধ করার নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা4.40

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    দ্রবণ কমিটির সংবিধানের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠা4.48

    লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা4.68

    লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    একটি লিকুইডেটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠা4.33

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    9 পৃষ্ঠা2.34B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    3 পৃষ্ঠা2.23B

    ক্রেডিটর কমিটির গঠনের সংশোধিত শংসাপত্র

    1 পৃষ্ঠা2.26B

    DALERI LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LAY, Mark Andrew George
    3 Oxford Court
    OX25 3QZ Weston On The Green
    Oxfordshire
    সচিব
    3 Oxford Court
    OX25 3QZ Weston On The Green
    Oxfordshire
    British91938760001
    DAWE, Angus Michael Mcneil
    22 Lady Place
    Sutton
    OX14 4FB Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    22 Lady Place
    Sutton
    OX14 4FB Abingdon
    Oxfordshire
    British65992690002
    LAY, Mark Andrew George
    3 Oxford Court
    OX25 3QZ Weston On The Green
    Oxfordshire
    পরিচালক
    3 Oxford Court
    OX25 3QZ Weston On The Green
    Oxfordshire
    British91938760001
    LEES, Robert James
    43a Sandford Lane
    Kennington
    OX1 5RW Oxford
    পরিচালক
    43a Sandford Lane
    Kennington
    OX1 5RW Oxford
    British63063860005
    RICHARDSON, Michael Douglas
    19 Lansdowne Road
    Dry Sandford
    OX13 6EA Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    19 Lansdowne Road
    Dry Sandford
    OX13 6EA Abingdon
    Oxfordshire
    British68601200001
    LEES, Robert James
    43a Sandford Lane
    Kennington
    OX1 5RW Oxford
    সচিব
    43a Sandford Lane
    Kennington
    OX1 5RW Oxford
    British63063860005
    WAYNE, Harold
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    মনোনীত সচিব
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    British900005490001
    SHARPE, Michael
    4 Cedar Park
    High Road
    IG7 5AL Chigwell
    Essex
    পরিচালক
    4 Cedar Park
    High Road
    IG7 5AL Chigwell
    Essex
    British93692100001
    WAYNE, Yvonne
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    মনোনীত পরিচালক
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish900005480001

    DALERI LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite all assets guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ge Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 07 february 2003 issued by the company
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest of the company in or arising out of a factoring, invoice discounting, or sales ledger financing, agreement;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Fixed and floating charge over all assets
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys payable to the company and all other rights the company may have under a business finance agreement dated 12 april 2000. all right title property and interest (if any) that the company may have in and to the debts and to the related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nmb-Heller Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ মে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ নভে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    DALERI LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০২ জুন, ২০০৫প্রশাসন শেষ
    ১৭ মার্চ, ২০০৫প্রশাসন শুরু
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Alan Michael Hudson
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Michael David Rollings
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৭ ডিসে, ২০১১ভেঙে গেছে
    ০২ জুন, ২০০৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Michael David Rollings
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    অভ্যাসকারী
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Andrew John Pepper
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    অভ্যাসকারী
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    অভ্যাসকারী
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Neil Hunter Cooper
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    অভ্যাসকারী
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0