MALMAISON (READING) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMALMAISON (READING) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03932085
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MALMAISON (READING) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হোটেল এবং অনুরূপ থাকার জায়গা (55100) / সংস্থাপন এবং খাদ্য পরিষেবা কার্যক্রম

    MALMAISON (READING) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Appold Street
    EC2A 2HB London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MALMAISON (READING) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MWB FRIAR STREET TWO LIMITED২৪ মে, ২০০০২৪ মে, ২০০০
    MWB CANNON CENTRE LEASE LIMITED ১২ মে, ২০০০১২ মে, ২০০০
    FINLAW 207 LIMITED২৩ ফেব, ২০০০২৩ ফেব, ২০০০

    MALMAISON (READING) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৫

    MALMAISON (READING) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ জুন, ২০১৬ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ নভে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ জানু, ২০১৬

    ১৯ জানু, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 15 Appold Street London EC2A 2HB এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    ২২ জুন, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা One Fleet Place London EC4M 7WS থেকে 15 Appold Street London EC2A 2HBপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১৭ জুন, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Wfw Legal Services Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    চার্জ 039320850008 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ১৭ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gary Reginald Davis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ ডিসে, ২০১৪

    ২৩ ডিসে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা One Fleet Place London EC4M 7WS এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    সম্পত্তি বা উদ্যোগের একটি অংশ মুক্ত করা হয়েছে এবং আর চার্জ 039320850008 এর অংশ নয়

    5 পৃষ্ঠাMR05

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    11 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    চার্জ নিবন্ধন 039320850008

    94 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ নভে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ ডিসে, ২০১৩

    ১৭ ডিসে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    ৩০ নভে, ২০১৩ তারিখে Paul Roberts-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    MALMAISON (READING) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WFW LEGAL SERVICES LIMITED
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর1648390
    18093320001
    ROBERTS, Paul
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    পরিচালক
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    United KingdomBritishFinance Director168184220001
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    সচিব
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    BritishAccountant100895090001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    কর্পোরেট সচিব
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    পরিচালক
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritishCompany Director34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor9320160002
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritishCompany Director53724380001
    COOK, Robert Barclay
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    পরিচালক
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    United KingdomBritishChief Executive Officer136758210001
    DAVIS, Gary Reginald
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    England
    পরিচালক
    EC4M 7WS London
    One Fleet Place
    England
    EnglandBritishCeo167510270002
    ELLIOT, Colin David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    পরিচালক
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritishFinance Director154267590001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    পরিচালক
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritishDirector69263980002
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector132613500001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    পরিচালক
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilianCompany Director51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    পরিচালক
    West Garden Place
    Kendal Street
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritishDirector121710890001
    FILEX NOMINEES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    কর্পোরেট পরিচালক
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    67847560001

    MALMAISON (READING) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h and l/h land under t/no's BK149209 (f/h) and BK128232 (l/h) and k/a the malmaison hotel station road reading.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১১ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৮ নভে, ২০১৪সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    • ২২ জুন, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Original Lenders and the Agent) (the Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ এপ্রি, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুন, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to each of the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge all its right,title benefit and interest (present and future) in the construction documentation. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to each of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Great western house station road reading t/nos bk 149209 and bk 128232 the rental sums the proceeds of each policy of insurance all buildings structures plant and machinery the goodwill floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to each of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Great western house station road reading part t/no BK149209, part t/no BK128232 and part t/no BK379001. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage the property and its interest in all existing and future fittings plant equipment machinery tools furniture and other tangibel moveable property situate on at the property. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies owed to the beneficiaries (as defined) under or in connection with the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুন, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0