SPIRIT (PSC) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSPIRIT (PSC) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03946005
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেনা
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SPIRIT (PSC) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • পাব এবং বার (56302) / সংস্থাপন এবং খাদ্য পরিষেবা কার্যক্রম

    SPIRIT (PSC) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SPIRIT (PSC) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PUNCH SUPPLY COMPANY LIMITED০১ মার্চ, ২০০২০১ মার্চ, ২০০২
    PUNCH GROUP (SUPPLY) LIMITED২৭ এপ্রি, ২০০০২৭ এপ্রি, ২০০০
    TRUSHELFCO (NO.2625) LIMITED১৩ মার্চ, ২০০০১৩ মার্চ, ২০০০

    SPIRIT (PSC) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৯ এপ্রি, ২০১৮

    SPIRIT (PSC) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    11 পৃষ্ঠাLIQ13

    ১৫ জানু, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    10 পৃষ্ঠাLIQ03

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    5 পৃষ্ঠাLIQ01

    ২৭ জানু, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom থেকে Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JUপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৬ জানু, ২০২০ তারিখে

    LRESSP

    ১৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৯ এপ্রি, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    ১৩ মার্চ, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ৩১ জানু, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kirk Dyson Davis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ জানু, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Richard Smothers-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    ১৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০১ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    ২৫ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Lindsay Anne Keswick-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ২৫ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Claire Susan Stewart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ মার্চ, ২০১৬

    ১৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4
    SH01

    ০৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ থেকে Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QTপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২২ আগ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ২৬ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Robert Langford এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Daryl Antony Kelly এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Lucy Jane Bell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২১ ডিসে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kirk Dyson Davis-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৪ ডিসে, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Henry Jones এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    SPIRIT (PSC) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    সচিব
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524420001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    পরিচালক
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    সচিব
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592320001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    সচিব
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445900001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    সচিব
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    RUDD, Susan Clare
    Parva House
    Church Farm Court Pipe Ridware
    WS15 3QL Rugeley
    Staffordshire
    সচিব
    Parva House
    Church Farm Court Pipe Ridware
    WS15 3QL Rugeley
    Staffordshire
    British81789210001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181022360001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    সচিব
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    CAMPBELL, Lloyd Anthony
    Beck House
    Lund House Green,Hill Top Lane
    HG3 1QG Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Beck House
    Lund House Green,Hill Top Lane
    HG3 1QG Harrogate
    North Yorkshire
    British2707710002
    COX, Philip Robert
    Stone Garth
    Crowhill Lane
    HG3 2LG High Birstwith
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Stone Garth
    Crowhill Lane
    HG3 2LG High Birstwith
    North Yorkshire
    British58419290005
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HYMAN, Alan Neil
    The Campions 42 Beech Hill Avenue
    Hadley Wood
    EN4 0LU Barnet
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Campions 42 Beech Hill Avenue
    Hadley Wood
    EN4 0LU Barnet
    Hertfordshire
    British43096700002
    JONAS, Marc Nicholas
    48 Oxford Gardens
    W10 5UN London
    পরিচালক
    48 Oxford Gardens
    W10 5UN London
    United KingdomBritish55841850003
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    পরিচালক
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    পরিচালক
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British43572470001
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    পরিচালক
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    MYERS, Roger
    Fern Lodge
    5 Millfield Lane Highgate
    N6 6JL London
    পরিচালক
    Fern Lodge
    5 Millfield Lane Highgate
    N6 6JL London
    United KingdomBritish56413030004
    OSMOND, Hugh
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    পরিচালক
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    British6209210002
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    PRESTON, Neil David
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    পরিচালক
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    United KingdomBritish63043630002
    RALSTON, Peter Christopher
    59 Molyneux Drive
    SW17 6BB London
    পরিচালক
    59 Molyneux Drive
    SW17 6BB London
    British69415940001

    SPIRIT (PSC) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর4271971
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    SPIRIT (PSC) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৬ জানু, ২০২০ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৫ এপ্রি, ২০২২ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    অভ্যাসকারী
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    অভ্যাসকারী
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0