SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 03998112
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য উৎপাদন (বিস্তারিত নির্দিষ্ট নয়) (32990) / উৎপাদন

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Henkel Limited
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HAMSARD 2200 LIMITED১৯ মে, ২০০০১৯ মে, ২০০০

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Application to strike off 03/05/2023
    RES13

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১০ জানু, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter David Budden এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ জানু, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Liam Anthony Murphy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ মে, ২০১৫

    ১৯ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    ২৩ জুল, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Apollo Court 2 Bishop Square Business Park Hatfield Herts AL10 9EY থেকে Henkel Limited Wood Lane End Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4RQপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ মে, ২০১৪

    ১৯ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ২১ জানু, ২০১৪ তারিখে Mr Peter David Budden-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    সচিব হিসাবে Sutinder Bhandal-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে David Graham এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BHANDAL, Sutinder
    Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    5
    Warwickshire
    Uk
    সচিব
    Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    5
    Warwickshire
    Uk
    British174260500001
    BHANDAL, Sutinder Singh
    5 Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    5 Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritish113815020001
    GRAHAM, David Richard
    32 Monkhams Lane
    IG8 0NS Woodford Green
    Essex
    সচিব
    32 Monkhams Lane
    IG8 0NS Woodford Green
    Essex
    British7345980001
    STEWARD, Andrew
    8 Carrion View
    S81 8YZ Gateford
    Nottinghamshire
    সচিব
    8 Carrion View
    S81 8YZ Gateford
    Nottinghamshire
    British73836180002
    BUDDEN, Peter David
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Henkel Limited
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Henkel Limited
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish114395690003
    CORK, James William
    1 Marlborough Court
    NG24 4PT Newark
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    1 Marlborough Court
    NG24 4PT Newark
    Nottinghamshire
    British73836260001
    COVALT, Robert Byron
    7517 West Bull Valley
    Road
    Mchenry
    Illinois 60050
    Usa
    পরিচালক
    7517 West Bull Valley
    Road
    Mchenry
    Illinois 60050
    Usa
    American5288740001
    HOWELL JONES, Martin
    3 Peacock Court
    20 South Park Road
    SW19 8SX Wimbledon
    পরিচালক
    3 Peacock Court
    20 South Park Road
    SW19 8SX Wimbledon
    EnglandBritish79974450001
    JARVIS, Timothy Hugh
    2 Park Lane
    LS3 1ES Leeds
    পরিচালক
    2 Park Lane
    LS3 1ES Leeds
    British72690800001
    MEIER, Anke
    Simon Meister Strasse 13
    50733 Cologne
    Germany
    পরিচালক
    Simon Meister Strasse 13
    50733 Cologne
    Germany
    British95320690002
    MURPHY, Liam Anthony
    St Joseph's Avenue
    Station Road
    IRISH Newbridge
    County Kildare
    Ireland
    পরিচালক
    St Joseph's Avenue
    Station Road
    IRISH Newbridge
    County Kildare
    Ireland
    IrelandIrish95686630001
    PACE, Louis Michael
    2607 W Huron Street
    FOREIGN Chicago
    60612 Illinois
    Usa
    পরিচালক
    2607 W Huron Street
    FOREIGN Chicago
    60612 Illinois
    Usa
    American72627550002
    SMITH, Terry Dan
    155 Samoa Drive
    Akron
    Ohio 44319
    United States
    পরিচালক
    155 Samoa Drive
    Akron
    Ohio 44319
    United States
    United StatesAmerican164946460001
    HAMMOND SUDDARDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008740001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008750001

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jp Morgan Chase Bank as Security Trustee for the Secured Parties (The "Administrative Agent")
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ নভে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Share pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and obligations due from the company to the chargee and/or the secured parties under the credit agreement and other loan documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    185 registered shares of the company numbered from 1 to 185 (the shares) any dividends and any other monies which would be due to the holder of the shares.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank the (Administrative Agent) as Security Trustee Foritself and the Other Agents Lender Parties and Hedge Banks Banks (as Defined)
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ নভে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Quota pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Us$93,587.00 Which amount was borrowed by the company from the lenders and advanced to the company as an intercompany loan to fund the company's purchase of certain assets of croda italiana spa as part of the croda acquisition as defined
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A continuing first priority security interest in and to all of the right title and interest of the pledgor in the quotas under clause 2 of the pledge under clause 5 of the pledge it was agreed that the pledge constitutes a continuing security to the pledgee for the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank for Its Own Account and on Behalf of Certainlenders
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ নভে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the secured parties and/or any reciever under or in connection with the loan documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bankthe ("Administrative Agent") as Security Trustee for Itself and the Other Agents, Lender Parties and Hedge Banks (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ নভে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0