DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামDIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04036009
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য টেলিকমিউনিকেশন কার্যক্রম (61900) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    NEXTIRAONE UK LIMITED০২ সেপ, ২০০২০২ সেপ, ২০০২
    ALCATEL E-BUSINESS DISTRIBUTION LIMITED২১ সেপ, ২০০০২১ সেপ, ২০০০
    BLAKEDEW 256 LIMITED১৮ জুল, ২০০০১৮ জুল, ২০০০

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৬

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    ১০ অক্টো, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Anne Colette Jacqueline Thonon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১০ অক্টো, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew David Coulsen এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ জুল, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৪ জুন, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ সেপ, ২০১৭ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ২৭ সেপ, ২০১৭ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 26,723,348
    3 পৃষ্ঠাSH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    26 পৃষ্ঠাAA

    ২৪ জুন, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Dimension Data Holdings Plc এর বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাPSC02

    ২৯ আগ, ২০১৬ তারিখে Ms Anne Colette Jacqueline Thonon-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    30 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ জুন, ২০১৬

    ২৪ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 26,723,347
    SH01

    ২১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Francis Cooper-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Calvin Paul Wesley Goom এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ জুল, ২০১৫

    ২০ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 26,723,347
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    28 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০১৪ থেকে ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    ০২ ফেব, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Paul Francis Cooper-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০২ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Calvin Paul Wesley Goom-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০২ ফেব, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Clare Horner এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০২ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Steven Murray Skakel এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    30 পৃষ্ঠাAA

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COOPER, Paul Francis
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    সচিব
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    194607120001
    COOPER, Paul Francis
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish206909290001
    HORNER, Clare
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    সচিব
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    British81932840001
    MAJURY, Robert Andrew
    24 Canterbury Road
    GU14 6NW Farnborough
    Hampshire
    সচিব
    24 Canterbury Road
    GU14 6NW Farnborough
    Hampshire
    British72155340001
    PENTER, Nicholas Trevor
    8 Cotsalls
    Fair Oak
    SO50 7HP Eastleigh
    Hampshire
    সচিব
    8 Cotsalls
    Fair Oak
    SO50 7HP Eastleigh
    Hampshire
    British81327550001
    SKAKEL, Steven Murray
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    সচিব
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    British29806610004
    BLAKELAW SECRETARIES LIMITED
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    কর্পোরেট সচিব
    Harbour Court
    Compass Road North Harbour
    PO6 4ST Portsmouth
    Hampshire
    38915800008
    ANE, Jerome Philippe
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Darwin House
    Staffordshire
    পরিচালক
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Darwin House
    Staffordshire
    FranceFrench148831600001
    BERTHELON, Jean Jacques
    59 Boulevard Beausejour
    FOREIGN Paris
    Paris 75116
    France
    পরিচালক
    59 Boulevard Beausejour
    FOREIGN Paris
    Paris 75116
    France
    French114410380001
    COULSEN, Andrew David
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    SwitzerlandBritish87390090003
    DOWNIE, Ian Michael Stuart
    Beech Hill
    Easton
    SO21 1ED Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    Beech Hill
    Easton
    SO21 1ED Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish81327720001
    GIBBS, Simon Spencer
    Weedon Lodge Farm House
    East End
    HP22 4NJ Weedon
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Weedon Lodge Farm House
    East End
    HP22 4NJ Weedon
    Buckinghamshire
    EnglandBritish90259420001
    GOOM, Calvin Paul Wesley
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritish194584790001
    KAYLOR, Donald Graham
    1 Styperson Way
    Poynton
    SK12 1UJ Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    1 Styperson Way
    Poynton
    SK12 1UJ Stockport
    Cheshire
    British73180690001
    LEWIS, David Andrew
    17 Mill Road
    CF14 0XA Cardiff
    পরিচালক
    17 Mill Road
    CF14 0XA Cardiff
    United KingdomBritish63310660001
    MAJURY, Robert Andrew
    24 Canterbury Road
    GU14 6NW Farnborough
    Hampshire
    পরিচালক
    24 Canterbury Road
    GU14 6NW Farnborough
    Hampshire
    EnglandBritish72155340001
    PENTER, Nicholas Trevor
    8 Cotsalls
    Fair Oak
    SO50 7HP Eastleigh
    Hampshire
    পরিচালক
    8 Cotsalls
    Fair Oak
    SO50 7HP Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritish81327550001
    SALVAGE, James Lloyd
    Lissom Shaw Rickmanhill Road
    CR5 3LA Chipstead
    Surrey
    পরিচালক
    Lissom Shaw Rickmanhill Road
    CR5 3LA Chipstead
    Surrey
    British50498550001
    SKAKEL, Steven Murray
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    29 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish29806610004
    THONON, Anne Colette Jacqueline
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    Darwin House
    Lichfield South Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    LuxembourgBelgian146053560002
    WINN, David Charles
    NL-1016 Ex Amsterdam
    Keizersgracht 302 1v
    পরিচালক
    NL-1016 Ex Amsterdam
    Keizersgracht 302 1v
    The NetherlandsIrish150733800001
    BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED
    New Court
    1 Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    Hampshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    New Court
    1 Barnes Wallis Road
    PO15 5UA Fareham
    Hampshire
    67781590002
    NEXTIRAONE EUROPE HOLDINGS BV
    Laan Van's-Gravenmade 24
    2495 Aj's
    Gravenhage
    Netherlands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Laan Van's-Gravenmade 24
    2495 Aj's
    Gravenhage
    Netherlands
    114409680001
    RKO MANAGEMENT AND INVESTMENT B.V.
    Laan Van `S-Gravenmade 24
    `S-Gravenhage
    2495 Aj
    Netherlands
    কর্পোরেট পরিচালক
    Laan Van `S-Gravenmade 24
    `S-Gravenhage
    2495 Aj
    Netherlands
    117640790001

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Dimension Data Holdings Plc
    Waterfront Business Park
    Fleet Road
    GU51 3QT Fleet
    Dimension Data House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Waterfront Business Park
    Fleet Road
    GU51 3QT Fleet
    Dimension Data House
    England
    না
    আইনি ফর্মPublic Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানRegistrar Of Companies, England & Wales
    নিবন্ধন নম্বর3704278
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মে, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Electro Banque S.A
    ব্যবসায়
    • ০১ মে, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২১ জানু, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A first fixed equitable charge over the deposit £306,315.45. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Linfield Assets LLP
    ব্যবসায়
    • ২০ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ এপ্রি, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First legal fixed charge over rent deposit of £164,590.00 and any interest thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Api (No 16) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge over credit balances
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Barclays bank PLC re alcatel e-businessdistribution limited business premium account number 50126586. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0