FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামFIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04096014
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    West Point 501 Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED২৯ নভে, ২০০১২৯ নভে, ২০০১
    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED২৫ অক্টো, ২০০০২৫ অক্টো, ২০০০

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০১৩
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০১৪
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠা4.71

    ০৩ সেপ, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠা4.68

    ১২ সেপ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ England থেকে West Point 501 Chester Rd Old Trafford Manchester M16 9HUপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৪ সেপ, ২০১৪ তারিখে

    LRESSP

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৩ অক্টো, ২০১৩

    ২৩ অক্টো, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,358,129
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৮ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে John Flood এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    সচিব হিসাবে Sherard Secretariat Services Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    সচিব হিসাবে Paul Birch এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Latham Nelson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Melvyn Ewell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Ian Fraser এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে David Arnold এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr Ian Ellis Fraser-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr David Llewelyn Arnold-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    West Point 501
    পরিচালক
    Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    West Point 501
    United KingdomBritish76116640002
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    পরিচালক
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    পরিচালক
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritish36191090003
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    সচিব
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    British36153790001
    O'MALLEY, Ann Marie
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    সচিব
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British38211680002
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    সচিব
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British25364820002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181213200001
    BIRCH, Iain Harvey
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish116126370001
    FLOOD, John Joseph
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish73695830003
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUk28393850006
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish36153790001
    GREENBURY, Lee
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish61478920003
    KEOGH, Sean
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish123405900001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish51438040006
    MALONEY, John Gerard
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Irish96964980001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish96596920001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish17129800004
    O'MALLEY, Desmond Francis
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    British55097840001
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    পরিচালক
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British25364820002
    THORNTON, James Stephen
    9 Hilly Croft
    Bromley Cross
    BL7 9HN Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    9 Hilly Croft
    Bromley Cross
    BL7 9HN Bolton
    Lancashire
    British67569070001

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ জুল, ২০১৩একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 and
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property being land and buildings on the north west side of queen street, farnworth, t/no GM86886.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ০৯ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মার্চ, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 (the "debenture deed of accession")
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficaries (As Each Termis Defined in the Debenture Deed of Accession)
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ মার্চ, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 18TH may 2001 and any other monies under the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Enterprise PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জুন, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ নভে, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৪ সেপ, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৯ এপ্রি, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    অভ্যাসকারী
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0