BLSSP (PHC 25) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBLSSP (PHC 25) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04104025
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BLSSP (PHC 25) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    BLSSP (PHC 25) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BLSSP (PHC 25) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০২০

    BLSSP (PHC 25) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২৭ সেপ, ২০২১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.00
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Application to strike off 23/09/2021
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০২ এপ্রি, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    21 পৃষ্ঠাAA

    ০৭ আগ, ২০২০ তারিখে Mr James Michael Pinkstone-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০২ এপ্রি, ২০২০ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ০৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Hursh Shah এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Watson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Andrew Honeyman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Philip Gallier এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে David William Pilbeam এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ মার্চ, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Bruce Richardson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Philip Gallier-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৩ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Martyn Stephen Burke এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 4 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ২৬ নভে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dean Clegg এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ নভে, ২০১৯ তারিখে Mr David William Pilbeam-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৬ নভে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David William Pilbeam-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    BLSSP (PHC 25) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর8992198
    187856670001
    COWEN, Geraint Jamie
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director141040000003
    PINKSTONE, James Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishCorporate Finance Executive241498640002
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    সচিব
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    পরিচালক
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    ATKINSON, William Stephen
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Surveyor174566650001
    BAGULEY, Peter Jeffrey
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    পরিচালক
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    United KingdomBritishChartered Surveyor175617500001
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    পরিচালক
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BELL-BROWN, Philip
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director119073370001
    BIRCH, John Matthew
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director191027500001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    পরিচালক
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    পরিচালক
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    BURKE, Martyn Stephen
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director152531940004
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    পরিচালক
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CLEGG, Dean
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director189632520001
    COHEN, Carolina Alfred
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishInvestment Executive248093020001
    FLEMING, Richard Alexander
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant125990210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    FRANCIS, Luke Thomas
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant223122340001
    GALLIER, Philip
    Rutherford Heights
    Rodney Road
    SE17 1AS London
    805
    United Kingdom
    পরিচালক
    Rutherford Heights
    Rodney Road
    SE17 1AS London
    805
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Reporting Manager265528310001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    পরিচালক
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HONEYMAN, James Andrew
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor201179510001
    HOORN, Antony John Van Der
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director170891040001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    পরিচালক
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    পরিচালক
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEWIS, Bryan John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor58257940003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচালক
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    পরিচালক
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001

    BLSSP (PHC 25) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Blssp Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    BLSSP (PHC 25) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land and buildings on the north side of lockstock lane bamber bridge preston south ribble lancashire t/no LA713241 and f/h land on the north side of locktock lane bamber bridge preston south ribble lancashire t/no LA591037 fixed charge all rental income any guarantee of rental income,its rights under any security or deposit agreement or arrangement see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Trust Company Limited ("Borrower Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২৩ এপ্রি, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Borrower deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৬
    অর্জিত হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights title and interest in the existing nominee property assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Trust Company Limited ("Borrower Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ২০১৩অধিগ্রহণের নিবন্ধন (MG06)
    • ১৯ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Borrower deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Please refer to form 395 for details of properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee) on Trust for Itself and the Otherborrower Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ০৯ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ ডিসে, ২০১৯একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A supplemental borrower deed of charge supplemental to the borrower deed of charge dated 20 june 2001
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ আগ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all of its interest in the charged additional mortgaged property. All its rights under the agreement and declaration of trust and deed of instruction and indemnity. All fixtures owned by it at the charged additional mortgaged property and its interest in any fixtures in its possession. Its interest in all benefits in respect of the insurances to the extent that they relate to the charged additional mortgaged property.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as Secured Note Trustee
    ব্যবসায়
    • ২৮ আগ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar")
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as the Trustee Pursuant to Thesecured Note Trust Deed (The "Secured Note Trustee") on Trust for Itself and the Other Borrowersecured Parties
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0