GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04113718
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    EARTHBOX LIMITED২৪ নভে, ২০০০২৪ নভে, ২০০০

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২২ ডিসে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduce share prem a/c 13/10/2015
    RES13

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১৫ থেকে ৩০ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Mr Colin Edward Lewis-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Jonathan Ross Brodie-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Mr Giles Henry Sharp-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ অক্টো, ২০১৫ তারিখে Joanne Elizabeth Massey-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ২৩ অক্টো, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG থেকে Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WPপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jon William Mortimore এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ জানু, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Giles Sharp-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১২ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil Fitzsimmons এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 1 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 10 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    ১৫ ডিসে, ২০১৪ তারিখে Joanne Elizabeth Massey-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ নভে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ নভে, ২০১৪

    ২৪ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৪ নভে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ নভে, ২০১৩

    ২৫ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    সচিব
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808010001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    পরিচালক
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    পরিচালক
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    পরিচালক
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    সচিব
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    সচিব
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    1 Martlesham
    AL7 2QF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    সচিব
    1 Martlesham
    AL7 2QF Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British72249480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    পরিচালক
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    পরিচালক
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    EnglandBritish98235420004
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    পরিচালক
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    পরিচালক
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritish1898090001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    পরিচালক
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    পরিচালক
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British3079600001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002
    YARDLEY, Norman
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153904770001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GLADEDALE URBAN DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each residential obligor to any residential secured party and from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects k/a and forming 159 ingram street glasgow and 97, 99, 99, an 101 hutcheson street glasgow, t/no.GLA143786 see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each residential obligor to any residential secured party and from each commercial obligor to any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and whole the subjects k/a and forming 163-167 ingram street glasgow being the basement ground and first floor premises, t/no.GLA115087 see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ সেপ, ২০০৯
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৪ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২বিবৃতি যে সম্পত্তির একটি অংশ বা সমস্ত চার্জ মুক্তি পেয়েছে (MG04)
    • ০৭ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A bond and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The charged assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৪ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property being 190 to 196 (even numbers) and 198A kennington park road, kennington t/n SGL90575.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a crown and sceptre house, bridge street, hitchin t/n HD236815.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold property being land on the east side of reading road streatley t/n BK10836, land and buildings on the south side of high street streatley t/n BK10837, streatley house high street streatley t/n BK9117 for further details of the property charged please refer to the form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০২ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A standard security which was presented in scotland for registration on 27 january 2004 and
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (First) all and whole the subjects at 159 ingram street glasgow and 97, 99 and 101 hutcheson street glasgow t/n GLA143786 and (second) all and whole the subjects known as 163 to 167 ingram street glasgow t/n GLA115087.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a new streets of london public house east moseley london t/n SY706112. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a greennside mills wakefield road dalton huddersfield and land and buildings lying to the south of wakefield road kirklees and land on the south side of wakefield road dalton huddersfield t/n WYK647046, WYK130371, and WYK656479. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0