NUPHARM LABORATORIES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNUPHARM LABORATORIES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04123795
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • মৌলিক ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদন (21100) / উৎপাদন
    • ফার্মাসিউটিক্যাল প্রস্তুতি উৎপাদন (21200) / উৎপাদন

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Newcastle Upon Tyne
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PHARMA FORMULATION SERVICES LIMITED১২ ডিসে, ২০০০১২ ডিসে, ২০০০

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জানু, ২০১৬

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    21 পৃষ্ঠাLIQ14

    ১৭ জুল, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1 st James Gate St. James Gate Newcastle upon Tyne NE1 4AD England থেকে Bulman House Regent Centre Gosforth Newcastle upon Tyne NE3 3LSপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ০৮ মে, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    26 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০৮ মে, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    23 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০৫ ডিসে, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christian Alexander Rigg এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Craig Robert Swinhoe এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাNDISC

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠা600

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    6 পৃষ্ঠাAM07

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    19 পৃষ্ঠাAM22

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    22 পৃষ্ঠাAM10

    চার্জ 041237950008 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    35 পৃষ্ঠাAM03

    প্রশাসক নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAM01

    ২৭ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Quantum House Hobson Industrial Estate Burnopfield County Durham NE16 6EA থেকে 1 st James Gate St. James Gate Newcastle upon Tyne NE1 4ADপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ১২ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    25 পৃষ্ঠাAA

    ০৮ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Gordon Trouton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৮ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Catherine Jane Brown এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৮ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brian James Fisher এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৬ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Catherine Jane Brown-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Christian Alexander Rigg-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৮ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Martin John Such এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ ডিসে, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Craig Robert Swinhoe-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MATTHEWS, Andrew Paul
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Bulman House
    Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Bulman House
    Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish196171710001
    SANSON, David Alan
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Bulman House
    Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    Regent Centre
    NE3 3LS Gosforth
    Bulman House
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish181607340001
    SWINHOE, Craig Robert
    St. James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    1 St James Gate
    England
    সচিব
    St. James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    1 St James Gate
    England
    205364300001
    TICKLE, Janice Mary
    38 Hatfield Gardens
    1 Appleton
    WA4 5QJ Warrington
    Cheshire
    সচিব
    38 Hatfield Gardens
    1 Appleton
    WA4 5QJ Warrington
    Cheshire
    British73620500001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BARKER, Michael Denis
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    EnglandBritish160393640002
    BROWN, Catherine Jane
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    পরিচালক
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    EnglandBritish206181820001
    FISHER, Brian James
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    EnglandBritish201469060001
    GOULD, William Michael
    Beacon Lane
    Heswall
    CH60 0EE Wirral
    Barnston House
    Merseyside
    England
    পরিচালক
    Beacon Lane
    Heswall
    CH60 0EE Wirral
    Barnston House
    Merseyside
    England
    United KingdomBritish79479020001
    RIGG, Christian Alexander
    St. James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    1 St James Gate
    England
    পরিচালক
    St. James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    1 St James Gate
    England
    United KingdomBritish202531540001
    SCAIFE, Andrew John
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    United KingdomBritish100960700008
    SUCH, Martin John
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    United KingdomBritish148239640001
    SWINHOE, Craig Robert
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    United KingdomBritish196021060001
    TICKLE, Stephen
    Beacon Lane
    Heswall
    CH60 0EE Wirral
    Barnston House
    Merseyside
    England
    পরিচালক
    Beacon Lane
    Heswall
    CH60 0EE Wirral
    Barnston House
    Merseyside
    England
    United KingdomBritish73620580001
    TROUTON, Andrew Gordon
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    EnglandBritish78745040001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    ১২ ডিসে, ২০১৬
    Hobson Industrial Estate
    Burnopfield
    NE16 6EA County Durham
    Quantum House
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর06775418
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুল, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ২০১৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    As more particularly described in clause 5 of the deed of accession to the debenture dated 10 july 2015, creating fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of nupharm laboratories limited.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৬ অক্টো, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৬ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    All assets debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৭ আগ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Finance Wales Investments (6) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৭ আগ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fielder pma 25/65 mixer granulator asset no:007. Gas chromatograph system 1 comprising: hewlett packard HP6890 series gc system asset:015. Hewlett packard HP6890 series injector asset no:017. For details of further chattels charged please refer to form MG01. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Genesis Asset Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৭ মার্চ, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জানু, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Caleva extruder and spheroniser serial no:1329/1089, zanasi capsule filler-model LZ764 serial no:01083, sanyo gallenkamp-stability cabinet 3-25/60 deg serial no:E070046, sanyo gallenkamp-stability cabinet 4-30/65 deg serial no:E009270,microfluidiser-model M110 serial no:9012 furthermore the company convenants with the bank that during the continuance of the security it will keep the mortgaged property free from liens distress execution or other legal process.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ মে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    NUPHARM LABORATORIES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৬ এপ্রি, ২০১৭প্রশাসন শুরু
    ০৯ মে, ২০১৮প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Allan David Kelly
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    অভ্যাসকারী
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Steven Phillip Ross
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    অভ্যাসকারী
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    2
    তারিখপ্রকার
    ০৯ মে, ২০১৮ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৩ অক্টো, ২০২১ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Steven Phillip Ross
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    অভ্যাসকারী
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Allan David Kelly
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    অভ্যাসকারী
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Steven Phillip Ross
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    অভ্যাসকারী
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    Allan David Kelly
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne
    অভ্যাসকারী
    1 St James Gate
    NE1 4AD Newcastle Upon Tyne

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0