PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04132575
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • স্টোর, স্টল বা বাজারের বাইরে অন্যান্য খুচরা বিক্রয় (47990) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত
    • অন্যান্য যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং স্পর্শযোগ্য পণ্য ভাড়া এবং লিজিং ন.এ.সি. (77390) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LAW 2251 LIMITED২৯ ডিসে, ২০০০২৯ ডিসে, ২০০০

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৬

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২৪ মে, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mark Peter Evans এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ২৪ মে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Peter Evans এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    22 পৃষ্ঠাAM23

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    28 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    40 পৃষ্ঠাAM03

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM06

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 2.14B

    19 পৃষ্ঠা2.16B

    ৩০ মার্চ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Unit 4 Boundary Court Willow Farm Business Park Castle Donington Derbyshire DE74 2UD থেকে Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    29 পৃষ্ঠাAA

    ০৯ ডিসে, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 15 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ ফেব, ২০১৬

    ০৩ ফেব, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 126,250
    SH01

    মাঝারি কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ জানু, ২০১৫

    ১২ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 126,250
    SH01

    ২৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Pinkney এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Wayne Homes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ মার্চ, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephen Vernon Bradley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    মাঝারি কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ জানু, ২০১৪

    ১৫ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 126,250
    SH01

    মাঝারি কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    মাঝারি কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    6 পৃষ্ঠাMG01

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ECCLESHALL, Christopher James
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    EnglandBritish100000660001
    EVANS, Mark Peter
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    সচিব
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    British78582200002
    FREARSON, Richard
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    সচিব
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    British50961700001
    EVERSECRETARY LIMITED
    1 Royal Standard Place
    NG1 6FZ Nottingham
    কর্পোরেট সচিব
    1 Royal Standard Place
    NG1 6FZ Nottingham
    60471940015
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    কর্পোরেট সচিব
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    61729550001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900018860001
    BRADLEY, Stephen Vernon
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish38805680002
    BRAMHALL, Darren
    Unit 9b
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UB Castle Donnington
    Derbyshire
    পরিচালক
    Unit 9b
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UB Castle Donnington
    Derbyshire
    United KingdomBritish139463440001
    BRAMHILL, Darren
    119 Park Lane
    DE74 2JG Castle Donington
    Derbyshire
    পরিচালক
    119 Park Lane
    DE74 2JG Castle Donington
    Derbyshire
    United KingdomBritish117298110001
    EVANS, Mark Peter
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 29
    West Yorkshire
    EnglandBritish78582200002
    FREARSON, Richard
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    পরিচালক
    4 Walnut Close
    Burnaston
    DE65 6PA Derby
    Derbyshire
    British50961700001
    HOMES, David Wayne
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154849800001
    PINKNEY, John
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Boundary Court
    Willow Farm Business Park
    DE74 2UD Castle Donington
    Unit 4
    Derbyshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154856180001
    RATCLIFFE, Eric George
    16 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    16 Beechwood Road
    HP9 1HP Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish32530880003
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008150001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ০৯ ডিসে, ২০১৬কোম্পানি জানে বা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা নেই

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over sub-hire agreements
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The secured property, being- all right title interest and benefit in and to the sub-hire agreements see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ নভে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery. 32FT x 10FT special jack leg unit. Fleet no:ccns-102 s/no 105/3/D531. 32FT x 10FT special jack leg unit. Fleet no: ccns-103 s/no 105/3/D532.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ ফেব, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Jack leg office/mess cabin units - s/nos 3/8062, 3/8063, s/8060, 3/8244, s/8692, 3/8957, 3/9056, 3/9070, 3/9101, 3/8982, N576, N594, N662, 3/8942. pallet racking s/no:B0051. Tiger hoist s/no's 777432-777437.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule such as welding stands and frames with dustribution boards and accessories. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    50 mastertig 350 mls welding machines,ser/nos 1108570,1108571,1108572 with all chattels plant machinery and things thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule being isuzu tf mega 2.5 tdi D. cab 4X4, chassis no. JAATFS54H27103683 pallet racking, s/no. D0336.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery 50 x mastertig 3500MLS welding machines serial numbers: 1096417, 1096418, 1097840 or any part thereof for further details of the property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things or any part thereof:- 53 mastertig 3500MLS welding machines s/nos, 1073780, 1079468, 992661, 1065190, 1065191, for further details of chattels charged with serial numbers please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto and the copy invoices attached hereto or any part thereof, schedule: vauxhall omega cdx V6, chassis no; WOLOVBM6911098696.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    William hackett chains limited invoice numbers: op/0017699, OP0018057, OP0018460, OP0018520, OP0018020, hessle fork trucks limited invoice number 111756. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the copy invoices attached to the form 395 or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Vauxhall frontera 3.2I vg estate,reg/no NY02 uaw with all plant machinery and equipment thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    2001 robin AR4001 digi multimeter - 5904. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge (all assets)
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (I) all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts including associated rights relating thereto and (ii) all amounts of indebtedness due on any account whatsoever, all goodwill and uncalled capital, all patents and patent applications. The floating charge over the remainder of the underatking and all propery rights and assets whatsoever and wheresoever, both present and future including the company's stock in trade and its uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PLANT AND CONSUMABLE SERVICES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৬ মার্চ, ২০১৭প্রশাসন শুরু
    ০৯ মার্চ, ২০১৮প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Anthony Steven Barrell
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castle Donington Derbyshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0