JSE DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামJSE DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04163466
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিজস্ব বা ভাড়াকৃত রিয়েল এস্টেটের অন্যান্য ভাড়া এবং পরিচালনা (68209) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    OVAL (1628) LIMITED২০ ফেব, ২০০১২০ ফেব, ২০০১

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৩

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    10 পৃষ্ঠা4.71

    ১৫ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 55 Baker Street London W1U 7EU থেকে 4 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells Kent TN1 1EEপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    7 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৭ মার্চ, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    3 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ মে, ২০১৪

    ০২ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Robert Game এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mark Keogh এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    ০১ ফেব, ২০১৩ তারিখে Mr Robert William Game-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ ফেব, ২০১৩ তারিখে Mr Mark William Keogh-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Kevin Martin Amor-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Jonathan Edward Taylor-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01

    সচিব হিসাবে Cargil Management Services Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    সচিব হিসাবে David Lanchester এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    England
    কর্পোরেট সচিব
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর02601236
    38636470004
    AMOR, Kevin Martin
    Wootton Lane
    HP17 8UY Dinton
    3
    Bucks
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wootton Lane
    HP17 8UY Dinton
    3
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant94937180002
    BAILEY, Clive Henry
    Laburnum House 289 Rectory Road
    Hawkwell
    SS5 4LA Hockley
    Essex
    পরিচালক
    Laburnum House 289 Rectory Road
    Hawkwell
    SS5 4LA Hockley
    Essex
    EnglandBritishManagement Accountant96018870001
    MAIKLEM, Miles Richard
    Eagle Way
    Warley
    CM13 3BW Brentwood
    1/653 Central Office
    Essex
    United Kingdom
    পরিচালক
    Eagle Way
    Warley
    CM13 3BW Brentwood
    1/653 Central Office
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishMarketing Manager70637730001
    TAYLOR, Jonathan Edward
    High Street
    HP17 8UN Dinton
    Mount Pleasant
    Bucks
    United Kingdom
    পরিচালক
    High Street
    HP17 8UN Dinton
    Mount Pleasant
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor139346680001
    GARDNER, Kamla Devi
    Flat 5
    21 Royal Crescent
    W11 4SL London
    সচিব
    Flat 5
    21 Royal Crescent
    W11 4SL London
    BritishAccountant81242540002
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    সচিব
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    PAEGETTER, Craoig Peter
    9 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4SF London
    সচিব
    9 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4SF London
    BritishDirector77025280001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant26086560001
    GAME, Robert William
    42 Upper Berkeley Street
    W1H 5EP London
    Meridien House
    United Kingdom
    পরিচালক
    42 Upper Berkeley Street
    W1H 5EP London
    Meridien House
    United Kingdom
    United KingdomEnglishChartered Surveyor139555050001
    GARDNER, Kamla Devi
    Flat 5
    21 Royal Crescent
    W11 4SL London
    পরিচালক
    Flat 5
    21 Royal Crescent
    W11 4SL London
    BritishAccountant81242540002
    KEOGH, Mark William
    42 Upper Berkeley Street
    W1H 5EP London
    Meridien House
    United Kingdom
    পরিচালক
    42 Upper Berkeley Street
    W1H 5EP London
    Meridien House
    United Kingdom
    EnglandIrishChartered Accountant62140690001
    PAEGETTER, Craoig Peter
    9 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4SF London
    পরিচালক
    9 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4SF London
    BritishDirector77025280001
    PROWTING, Roger George
    68 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    68 Chignal Road
    CM1 2JB Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishChartered Management Accountan76592730001
    ROSCOE, Antony David
    24 Hillcroft Crescent
    W5 2SQ London
    পরিচালক
    24 Hillcroft Crescent
    W5 2SQ London
    EnglandBritishDirector52996620001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    পরিচালক
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritishAccountant5689250001
    WEST, Stuart Charles
    Hailstone Close
    Hadlow
    TN11 0JY Tonbridge
    22
    Kent
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hailstone Close
    Hadlow
    TN11 0JY Tonbridge
    22
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishMarketing Manager130728390001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The properties k/a 3 to 5 mount ephraim and 5,6,7 and 8 culverdon street tunbridge wells t/no K733530. 12 invencible road farnborough t/no HP373809. 53 and 55 bishopric and land k/s tansfield bishopric t/no WSX124835.for further properties charged please refer to form MG01 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৪ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ আগ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 12 invincible road farnborough t/no HP373809, f/h property k/A53-59 bishopric horsham t/nos WSX124835ANS WSX144118, f/h property k/a aveburyavenue tonbridge t/no K462990 and f/h property k/a 3-15 (odd) mount ephraim AND5-8 culverden street tunbridge t/no K733. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ আগ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from james smith estates PLC to the chargee under the facility letter dated 27 april 2001
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a 12 invincible road farnborough hampshire t/n HP373809, an assignment of the rental sums, a fixed charge over all the company's plant, machinery and other items affixed to and forming part of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities which are now or in the future due, owing or incurred by the borrower to the bank under the facility letter dated 27 april 2001 (including any renewal or replacement facility letter referred to as the "facility letter")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the l/h property k/a 3-15 (odd) mount ephraim and 5, 6, 7 & 8 culverden street tunbridge wells t/n K733530 an assignment of the rental sums together with the benefit of all the company's rights and remedies relating to them a fixed charge over all the company's plant, machinery and other items affixed to and forming part of the property on or at any time after the date of the charge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities which are now or in the future due, owing or incurred by the borrower to the bank under the facility letter dated 27 april 2001 (including any renewal or replacement facility letter referred to as the "facility letter")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a 53/59 bishopric, horsham, west sussex t/ns WSX124835 and WSX144118 an assignment of the rental sums together with the benefit of all the company's rights and remedies relating to them a fixed charge over all the company's plant, machinery and other items affixed to and forming part of the property on or at any time after the date of the charge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities which are now or in the future due, owing or incurred by the borrower to the bank under the facility letter dated 27 april 2001 (including any renewal or replacement facility letter referred to as the "facility letter")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Legal mortgage over the l/h property k/a land and buildings on the south side of avebury avenue, tonbridge t/n K462990 an assignment of the rental sums together with the benefit of all the company's rights and remedies relating to them a fixed charge over all the company's plant, machinery and other items affixed to and forming part of the property on or at any time after the date of the charge. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money and liabilities due owing or incurred by james smith estates PLC (the borrower) to the chargee under the facility letter issued by the chargee to the borrower on 27 april 2001
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 128 high road woodford redbridge including all buildings and structures and fixtures (including trade and tenant's fixtures) rental sums and all plant machinery and other fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money and liabilities due owing or incurred by james smith estates PLC (the borrower) to the chargee under the facility letter issued by the chargee to the borrower on 27 april 2001
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a the interior of the underground car park at 140 high road woodford redbridge - EGL342062 including all buildings and structures and fixtures (including trade and tenant's fixtures and rental sums and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জুন, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    JSE DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৭ মার্চ, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১২ জুল, ২০১৬ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Newman
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    অভ্যাসকারী
    Crowe U.K. Llp 4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    Vincent John Green
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent
    অভ্যাসকারী
    4 Mount Ephraim Road
    TN1 1EE Tunbridge Wells
    Kent

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0