CPS NUMBER 4 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCPS NUMBER 4 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04165716
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CPS NUMBER 4 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • সমুদ্র এবং উপকূলীয় মালবাহী জল পরিবহন (50200) / পরিবহন এবং স্টোরেজ

    CPS NUMBER 4 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    No.1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CPS NUMBER 4 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ALNERY NO.2162 LIMITED২২ ফেব, ২০০১২২ ফেব, ২০০১

    CPS NUMBER 4 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৪

    CPS NUMBER 4 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    ০১ অক্টো, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Tui Travel House Crawley Business Quarter Fleming Way Crawley West Sussex RH10 9QL থেকে No.1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DPপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    4 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০১ সেপ, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ মে, ২০১৫

    ১৪ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১৯ ডিসে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mark Hattendorf-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Wilfried Rau এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ মে, ২০১৪

    ১৪ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Andrew John এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ০৯ মে, ২০১২ তারিখে Mrs Joyce Walter-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ২১ জুন, ২০১০ তারিখে Mr Andrew Lloyd John-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    সচিব হিসাবে Mrs Joyce Walter-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    CPS NUMBER 4 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WALTER, Joyce
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    সচিব
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    152272050001
    HATTENDORF, Mark
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    পরিচালক
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    GermanyGermanAccountant183404720001
    WALTER, Joyce
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    পরিচালক
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No.1
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Secretary76169540003
    BAKER, John Michael
    Pedlars
    The Chase
    KT20 6HZ Kingswood
    Surrey
    সচিব
    Pedlars
    The Chase
    KT20 6HZ Kingswood
    Surrey
    Canadian110901170001
    HILL, Elliot Robert Greatrex
    Flat 1
    143 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    সচিব
    Flat 1
    143 Holland Park Avenue
    W11 4UT London
    British99461490001
    MANSFELD, Thomas
    Zikadenweg
    FOREIGN 22043 Hamburg
    19e
    Germany
    সচিব
    Zikadenweg
    FOREIGN 22043 Hamburg
    19e
    Germany
    German117835010002
    SHARMAN, Carl John
    6 Days Green
    Capel St Mary
    IP9 2HZ Ipswich
    Suffolk
    সচিব
    6 Days Green
    Capel St Mary
    IP9 2HZ Ipswich
    Suffolk
    BritishChartered Accountant74436380003
    SHORT, Karen Margot
    The Tythe Barn
    TN21 9RG Rushlake Green
    East Sussex
    সচিব
    The Tythe Barn
    TN21 9RG Rushlake Green
    East Sussex
    BritishAccountant78988930002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BOYLAN, Alan Francis
    361 Chambersbury Lane
    HP3 8LW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    পরিচালক
    361 Chambersbury Lane
    HP3 8LW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    BritishDirector105598290003
    HARDS, Glenn
    36 Ratton Drive
    BN20 9BS Eastbourne
    East Sussex
    পরিচালক
    36 Ratton Drive
    BN20 9BS Eastbourne
    East Sussex
    BritishDirector102419860001
    JOHN, Andrew Lloyd
    Crawley Business Quarter
    Fleming Way
    RH10 9QL Crawley
    Tui Travel House
    West Sussex
    পরিচালক
    Crawley Business Quarter
    Fleming Way
    RH10 9QL Crawley
    Tui Travel House
    West Sussex
    United KingdomBritishLawyer75467790004
    KNIGHTLEY, Ian Geoffrey
    5 Old Rectory Gardens
    Occold
    IP23 7PD Eye
    Suffolk
    পরিচালক
    5 Old Rectory Gardens
    Occold
    IP23 7PD Eye
    Suffolk
    BritishDirector74138000001
    KRANICH, Ulrich
    Weidenkamp 4
    Handorf
    21447
    Germany
    পরিচালক
    Weidenkamp 4
    Handorf
    21447
    Germany
    GermanyGermanDirector108535400001
    NICKLIN, David Royston
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    পরিচালক
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    BritishDirector78465650001
    NICKLIN, David Royston
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    পরিচালক
    17 Saint Francis Gardens
    RH10 3JS Copthorne
    West Sussex
    BritishDirector78465650001
    RAU, Wilfried
    Hannover
    Bischofsholer Damm 34
    30173
    Germany
    পরিচালক
    Hannover
    Bischofsholer Damm 34
    30173
    Germany
    GermanyGermanDirector136733410001
    REEVE, Michael
    11 Tiberius Gardens
    CM8 1HJ Witham
    Essex
    পরিচালক
    11 Tiberius Gardens
    CM8 1HJ Witham
    Essex
    EnglandBritishDirector60778110001
    TORRENS, Iain William
    34 Church Avenue
    East Sheen
    SW14 8NN London
    পরিচালক
    34 Church Avenue
    East Sheen
    SW14 8NN London
    BritishDirector83364810001
    WALDING, Keith John
    Kintail
    Halldore Hill
    SL6 9EX Cookham
    Berkshire
    পরিচালক
    Kintail
    Halldore Hill
    SL6 9EX Cookham
    Berkshire
    BritishDirector46199600003
    WEBBER, Ian James
    The Farmyard
    Pearsons Green
    TN12 7DE Brenchley
    Kent
    পরিচালক
    The Farmyard
    Pearsons Green
    TN12 7DE Brenchley
    Kent
    BritishDirector54611490002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    CPS NUMBER 4 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Tripartitie general assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party on an account current under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The assigned contract rights and the proceeds thereof. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    General assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party on an account current under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The earnings of the ship; the insurances of the ship; any charter; any charter guarantee and any requisition compensation for the ship. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of covenant
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party on an account current under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the vessel "contship aurora" documented in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 906102.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    First priority statutory ship mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the security trustee or any other creditor party on an account current under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of the vessel "contship aurora" documented in the name of the owner under the laws and flag of the united kingdom under official number 906102. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ সেপ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Predelivery security assignment deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Predelivery security assignment deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Predelivery security assignment deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Predelivery security assignment deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Predelivery security assignment deed
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, the security parties or any of them to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights and interests now or at any later time in or in connection with each of the assigned contracts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জুন, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrowers, the security parties or any of them to the chargee or any other creditor party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the undertaking, assets and rights of the company both present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank International PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CPS NUMBER 4 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০১ সেপ, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৮ ফেব, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0