STADCO HOLDINGS LTD.

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSTADCO HOLDINGS LTD.
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04215953
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    STADCO HOLDINGS LTD. এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    STADCO HOLDINGS LTD. কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    International House Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    STADCO HOLDINGS LTD. এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    OFFSHELF 282 LTD১৪ মে, ২০০১১৪ মে, ২০০১

    STADCO HOLDINGS LTD. এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৭

    STADCO HOLDINGS LTD. এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    1 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ১৫ অক্টো, ২০১৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০৮ মে, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৮ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে Mr Mark John Smith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৮ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে Mr Christopher Paul Fisher-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    ০৮ মে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    ০৮ মে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ০৭ অক্টো, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RW থেকে International House Siskin Parkway East Middlemarch Business Park Coventry CV3 4PEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ০৫ সেপ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Mark John Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ০৫ সেপ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Michael Hayhurst এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ মে, ২০১৬

    ০৯ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 19,155,439
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ৩০ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Mark John Smith-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Christopher Paul Fisher-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gregory Ian Macleod এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Gordon Hussey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ২৯ ডিসে, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Stadco Queensway Hortonwood Telford Shropshire TF1 7LL থেকে Tachbrook Park 5 Apollo Way Warwick Warwickshire CV34 6RWপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    চার্জ 042159530006 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    STADCO HOLDINGS LTD. এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    সচিব
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    213570940001
    FISHER, Christopher Paul
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    পরিচালক
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish183747270001
    SMITH, Mark John
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    পরিচালক
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    United KingdomBritish124719430001
    HAYHURST, Michael
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    সচিব
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    British15201970002
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    সচিব
    Plas Onn Quinta
    Weston Rhyn
    SY10 7LW Oswestry
    Shropshire
    British10529040001
    OTHERS INTERESTS LTD
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    কর্পোরেট সচিব
    Churchill House
    47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    103784950001
    COOK, Jonathan Charles
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Backs
    38 South Parade, Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    British72559760001
    HUSSEY, David Gordon
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    পরিচালক
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    EnglandBritish131639570002
    HUSSEY, David Gordon
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Callingwood Lane
    Tatenhill
    DE13 9SH Burton-On-Trent
    Callingwood Hall
    Staffordshire
    United Kingdom
    British131639570001
    KYNASTON, Stephen Lloyd
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    পরিচালক
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    United KingdomBritish10529040001
    MACLEOD, Gregory Ian
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    পরিচালক
    5 Apollo Way
    CV34 6RW Warwick
    Tachbrook Park
    Warwickshire
    United KingdomAustralian60518160005
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    পরিচালক
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORGAN, Kelvin Brian
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    পরিচালক
    Manderley Ellesmere Road
    Harmer Hill
    SY4 3EE Shrewsbury
    Shropshire
    EnglandBritish74818010001
    MORRISS, Andrew Stuart
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    পরিচালক
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    EnglandBritish11643310001
    ROACHE, David John
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    পরিচালক
    Fallowfield
    Badgers Lane
    CV35 0BY Lower Tysoe
    Warwickshire
    United KingdomBritish40953790002
    STERNE, Dermot Desmond
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    পরিচালক
    Harlescott Lane
    Shrewsbury
    SY1 3AS Shropshire
    UkBritish96569780001
    SWORD, John David
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Chivel
    OX7 5TR Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish1600540001
    WILLIS, David John
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    পরিচালক
    Damson Cottage
    Highfields
    SY4 5UN Wem
    Shropshire
    British51085590002
    YOUENS, Michael Arthur
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    পরিচালক
    14 Westwood Drive
    The Mount
    SY3 8YB Shrewsbury
    Shropshire
    British36008490001
    OFFSHELF LTD
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Churchill House 47 Regent Road
    ST1 3RQ Stoke On Trent
    Staffordshire
    42228870001

    STADCO HOLDINGS LTD. এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Siskin Parkway East
    Middlemarch Business Park
    CV3 4PE Coventry
    International House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর555532
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    STADCO HOLDINGS LTD. এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Castle bromwich, fort parkway, fort dunlop, erdington,t/no: WM835446 & WM918474;. Land and buildings on the north side of harlescott lane, shrewsbury, t/no: SL100479; and. Unit a, fford y cain, cain valley trading estate, llanfyllin, t/no: WA725094, CYM389181 and CYM387145. (For details of all other property charged, please refer to the docs). Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Board of the Pension Protection Fund
    ব্যবসায়
    • ০৬ সেপ, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৬ ডিসে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Castle bromwich fort parkway fort dunlop erdington t/no.WM835446 and WM918474. Land and buildings on the north side of harlescott lane shrewsbury t/no.SL100479. Unit a, fford y cain cain valley trading estate llanfyllin t/no.WA725094, CYM389181 and CYM387145. Land and buildings to the west side of queensway trench lock interchange hadley telford t/no.SL21563, SL81932 and SL96965. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৪ সেপ, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৬ ডিসে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC 'Security Trustee'
    ব্যবসায়
    • ০১ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ ডিসে, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interests and other distributions, all accretions, rights benefits, money or property accruing.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জানু, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জানু, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Pledge of shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    926 shares in the share capital of the company numbered from 926 up to and including 1,851. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Known as Chase Manhattan International Limited) or Theother Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed to the target group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly K/a Chase Manhattan International Limited)
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0