MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিরিসিভার অ্যাকশন
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04248904
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    OCM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED০৪ সেপ, ২০০৩০৪ সেপ, ২০০৩
    CALDINE MANAGEMENT LIMITED০৯ জুল, ২০০১০৯ জুল, ২০০১

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মে, ২০০৯
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়২৮ ফেব, ২০১০
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০০৮

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৯ জুল, ২০১৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৩ জুল, ২০১৬
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ১৮ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাRM02

    ০৫ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৫ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৫ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৫ জানু, ২০১২ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ১৮ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠাLQ02

    ১৬ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ১৬ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ১৬ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৫ জুল, ২০১১ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    3 পৃষ্ঠাLQ01

    ১৬ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    পরিচালক হিসাবে Gerard O'connor এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed ocm property developments LIMITED\certificate issued on 25/08/09
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা405(1)

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    5 পৃষ্ঠা395

    legacy

    4 পৃষ্ঠা395

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ মে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    annual-return০৪ আগ, ২০০৭

    legacy

    363(288)

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MUNRO, Brian Martin
    The Laurels
    10 Hopefountain
    GU15 1JS Camberley
    Surrey
    সচিব
    The Laurels
    10 Hopefountain
    GU15 1JS Camberley
    Surrey
    IrishCompany Director71739370003
    MUNRO, Brian Martin
    The Laurels
    10 Hopefountain
    GU15 1JS Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    The Laurels
    10 Hopefountain
    GU15 1JS Camberley
    Surrey
    United KingdomIrishCompany Director71739370003
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    O'CONNOR, Gerard
    Greyhound Cottage
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    পরিচালক
    Greyhound Cottage
    1 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    United KingdomIrishCompany Director81856550002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 4 and 5 the drive kersal salford, fixed and floating charge over all property and assets present and future including uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Derbyshire Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ নভে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a 4 and 5 the drive kersal salford, fixed charge all plant, machinery, implements, utensils, furniture, equipment and the goodwill and assigns any rental income. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Derbyshire Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৬ নভে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মার্চ, ২০০৯একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (405 (1))
    • 1১২ নভে, ২০১১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (LQ02)
      • মামলা নম্বর 1
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Each of the l/h properties k/a apartments 5, 6 and 13 the oaks 157/159 bury old road salford and each being comprised in leases dated 27 april 2007, all land, the goodwill and core capital, the secrities, the debts, the asset contract floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Each of the l/h properties k/a apartments 5, 6 and 13 the oaks 157/159 bury old road salford and each being comprised in leases dated 27 april 2007. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ মে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Assignment by way of security
    তৈরি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The building contract made between the assignor and anthony clapham, alan saville and others trading as sa developments dated 13/12/2006 and all rights contained therein. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ২১ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    4 and 5 the drive kersal t/nos la 85509 and gm 165610 together with a fixed charge on all interests and a specific charge on the goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at 4 & 5 the drive off bury new road salford manchester t/nos la 85509 and gm 165610 together with a separate fixed charge the goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ নভে, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property known as 27 and 29 polygon road crumpsall manchester t/n GM350949 and LA227993, all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property, any present and future goodwill, moveable plant machinery and equipment on or about the property,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ১২ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £345,000.00 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jeffrey Turner and Vivien Rowena Turner
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £75,000.00 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Erik Alfred White and Elizabeth Anne White
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £35,000.00 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Kenneth Graham White
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £30,000.00 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Brian Isherwood and Georgina Gizella Isherwood
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the f/h property k/a 4 and 5 the drive kersal salford t/n LA85509 and GM165610. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the f/h property k/a 4 & 5 the drive salford t/n LA85509 and GM165610. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • 2১২ জুল, ২০১০একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (LQ01)
    • 2০১ জুল, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
      • মামলা নম্বর 2
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £25,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land situate at and k/a 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Graham Anthony Long and Betridge Long
    ব্যবসায়
    • ১৮ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Raymond Thorn
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £12,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Derek James Greenaway and Helen Greenaway
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Peter Thomas Barratt and Barbara Joan Barratt
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Peter James Evans and Wendy Anne Hughes
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £35,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Robert John Cockrill and Diane Margaret Cockrill
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £10,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Melanie Theresa Jones
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £14,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Brenda Mary Bance
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Dick Barley
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £15,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • William Martin Lofthouse
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £30,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 27 and 29 polygon road crumpsall manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • David Hugh Turner and Judith Diane Simpson
    ব্যবসায়
    • ০৪ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    MUNOC PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Andrew Burton Hughes
    Adler King
    Pembroke House
    BS8 3BA 15 Pembroke Road
    Clifton Bristol
    রিসিভার ম্যানেজার
    Adler King
    Pembroke House
    BS8 3BA 15 Pembroke Road
    Clifton Bristol
    Julian Paul Smith
    Alder King Llp Pembroke House
    15 Pembroke Road
    BS8 3BA Bristol
    Avon
    রিসিভার ম্যানেজার
    Alder King Llp Pembroke House
    15 Pembroke Road
    BS8 3BA Bristol
    Avon
    2রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Anne Clare O'Keefe
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    রিসিভার ম্যানেজার
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Simon Wilson
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    রিসিভার ম্যানেজার
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Kevin James Coates
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    রিসিভার ম্যানেজার
    Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0