OPAL (YORKSHIRE) LTD

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOPAL (YORKSHIRE) LTD
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04263388
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OPAL (YORKSHIRE) LTD এর উদ্দেশ্য কী?

    • ফি বা চুক্তিভিত্তিক ভিত্তিতে রিয়েল এস্টেট পরিচালনা (68320) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    OPAL (YORKSHIRE) LTD কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OPAL (YORKSHIRE) LTD এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    STYWAY PROPERTIES LIMITED০২ আগ, ২০০১০২ আগ, ২০০১

    OPAL (YORKSHIRE) LTD এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১২

    OPAL (YORKSHIRE) LTD এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    7 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৯ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৯ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২০ অক্টো, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Place Ducie Street Manchester M1 2TP থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ৩০ সেপ, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সমাপ্তির নোটিশ

    47 পৃষ্ঠা1.4

    ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brett Alan Lashley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Richard Spencer-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brett Alan Lashley-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Craig Allan Mellor এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stuart Barrie Wall এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Craig Allan Mellor এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gavin Robert Duncan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ মার্চ, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB থেকে The Place Ducie Street Manchester M1 2TPপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসনের সমাপ্তির নোটিশ

    72 পৃষ্ঠা2.32B

    ১০ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    67 পৃষ্ঠা2.24B

    ১৭ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাRM02

    রেজিস্ট্রারকে নোটিশ কোম্পানির স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার কার্যকরী

    9 পৃষ্ঠা1.1

    রিসিভার বা ম্যানেজারের নিযুক্তি

    4 পৃষ্ঠাRM01

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১০ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    90 পৃষ্ঠা2.24B

    OPAL (YORKSHIRE) LTD এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SPENCER, Richard James
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    পরিচালক
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish190526870001
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    সচিব
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    DUNCAN, Gavin Robert
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    পরিচালক
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish151512820001
    LASHLEY, Brett Alan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    পরিচালক
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandUnited States Of America196201790001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    পরিচালক
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish60906780002
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    OPAL (YORKSHIRE) LTD এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • 2১৮ নভে, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (RM01)
    • 2১৯ ডিসে, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
      • মামলা নম্বর 2
    Assignment by way of security
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right, title and interest in and to the agreements and all rights contained therein and all monies and/or benefits from time to time accruing thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ আগ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ আগ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ আগ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or its associated companies on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land at pitfield street youth centre pifield street hackney t/no EGL438260 the rental income the benefit of all guarantees the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুল, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property situate at the junction of thornton road and tumbling hill street bradford west yorks t/no WYK559561. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০১ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ সেপ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জানু, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the south side of tumbling hill street bradford t/n WYK681581. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ সেপ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জানু, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ সেপ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    OPAL (YORKSHIRE) LTD এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৮ মার্চ, ২০১৩প্রশাসন শুরু
    ২০ ফেব, ২০১৫প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2রিসিভার/ম্যানেজার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    রিসিভার ম্যানেজার
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    রিসিভার ম্যানেজার
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    3
    তারিখপ্রকার
    ১২ ডিসে, ২০১৪সিভিএ অনুমোদনের সভার তারিখ
    ২২ অক্টো, ২০১৫সিভিএ সম্পন্ন বা সমাপ্তির তারিখ
    কর্পোরেট স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা (সিভিএ)
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    4
    তারিখপ্রকার
    ৩০ সেপ, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০২ আগ, ২০১৯ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0