AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামAON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04301069
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স (65120) / আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Aon Centre The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LORICA CONSULTING LIMITED১৫ জুল, ২০০৫১৫ জুল, ২০০৫
    HEALTH FOR INDUSTRY LIMITED২৫ জানু, ২০০২২৫ জানু, ২০০২
    CONTACTBASE LIMITED০৯ অক্টো, ২০০১০৯ অক্টো, ২০০১

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    6 পৃষ্ঠা4.71

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৬ সেপ, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    ২১ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Charles Battle এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christine Marie Williams এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Alistair Patrick Boyd-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ আগ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Arthur Hogwood-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ সেপ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Tobin Mathew Murphy-Coles এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে James Neville Herbert এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Dec nom cap 20/11/2015
    RES13

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ৩০ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.01
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    বার্ষিক রিটার্ন ০৯ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ অক্টো, ২০১৫

    ২১ অক্টো, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 250,100
    SH01

    ১৩ জুল, ২০১৫ তারিখে Mr David Charles Battle-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 8 Devonshire Square London EC2M 4PL England থেকে 10 Devonshire Square London EC2M 4YP এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান 8 Devonshire Square London EC2M 4PL এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    ১৩ জুল, ২০১৫ তারিখে Cosec 2000 Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    ১৩ জুল, ২০১৫ তারিখে Christine Marie Williams-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৩ জুল, ২০১৫ তারিখে James Neville Herbert-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    COSEC 2000 LIMITED
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre, The Leadenhall Building
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre, The Leadenhall Building
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর03127178
    152185840001
    BOYD, Alistair Patrick
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    পরিচালক
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United KingdomBritish214544820001
    HOGWOOD, Paul Arthur
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    পরিচালক
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United KingdomBritish7453920005
    BUHAGIAR, Bryan
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    মনোনীত সচিব
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    British900011210001
    GODSELL, Jeanette Louise
    30 St Michaels Road
    GU47 8HE Sandhurst
    Berkshire
    সচিব
    30 St Michaels Road
    GU47 8HE Sandhurst
    Berkshire
    British75623730001
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    সচিব
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    সচিব
    39 Lynwood Grove
    BR6 0BD Orpington
    Kent
    British75598460002
    NEWELL, Mark Verity
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    সচিব
    Moffat Pains Hill
    Limpsfield Chart
    RH8 0RG Oxted
    Surrey
    British77855100001
    PEAKE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Wiltshire
    কর্পোরেট সচিব
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    Wiltshire
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর01887672
    55731680011
    BATTLE, David Charles
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish111477590002
    BEAUMONT, Peter Stuart
    Badgers Hollow
    Rowhills
    GU9 9AU Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Badgers Hollow
    Rowhills
    GU9 9AU Farnham
    Surrey
    British78770280001
    BIBBY, John
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    পরিচালক
    Plovers
    Tudor Close
    RH20 2E Pulborough
    West Sussex
    British27995540003
    BRADBURY, Susan Patricia
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Causeway Foot Rochdale Road
    Pole Moor Outlane
    HD3 3FQ Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish40471660002
    BRADLEY, Stephen Michael
    Little London Cottage
    61-62 High Street
    BA12 0EB Heytesbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    Little London Cottage
    61-62 High Street
    BA12 0EB Heytesbury
    Wiltshire
    EnglandBritish75623610001
    BUHAGIAR, Susan
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    মনোনীত পরিচালক
    14 Fernbank Close
    Walderslade
    ME5 9NH Chatham
    Kent
    United KingdomBritish900011200001
    CARTER, Patrick Robert
    Rue De Peuplier 7-9
    FOREIGN 1000 Brussels
    Belgium
    পরিচালক
    Rue De Peuplier 7-9
    FOREIGN 1000 Brussels
    Belgium
    British81585030001
    CLARIDGE-WARE, Christopher Maurice
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    The Grange
    Berkshire
    পরিচালক
    Fireball Hill
    SL5 9PJ Sunningdale
    The Grange
    Berkshire
    United KingdomBritish5828350004
    CONNELL, Alistair James
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    পরিচালক
    Devonshire Square
    EC2M 4PL London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish154274870002
    COOMBER, Karen Maria
    Moorhams Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4YG Basingstoke
    7
    Hampshire
    পরিচালক
    Moorhams Avenue
    Hatch Warren
    RG22 4YG Basingstoke
    7
    Hampshire
    EnglandBritish100159270003
    EDMANDS, David James Rosewall
    16 Kings Chase
    TN24 0LQ Ashford
    Kent
    পরিচালক
    16 Kings Chase
    TN24 0LQ Ashford
    Kent
    United KingdomBritish118042260001
    HERBERT, James Neville
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish164559940002
    HODES, Jonathan
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    পরিচালক
    81 Lauderdale Mansions
    Lauderdale Road
    W9 1LX London
    British79523100001
    JACKSON, John David, Mr.
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    পরিচালক
    Prospect Place
    SN1 3LJ Swindon
    Hardwick House
    United KingdomBritish166242060001
    JAMES, Philip William Henry
    Swan Building
    26 Victoria Street
    ML3 0LE Hamilton
    Lanarkshire
    Bermuda
    পরিচালক
    Swan Building
    26 Victoria Street
    ML3 0LE Hamilton
    Lanarkshire
    Bermuda
    British33901640005
    KEILL, Tracy Elizabeth
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    পরিচালক
    'Verandah House'
    8 Pokiok Road
    Smith's
    Fl05
    Bermuda
    British127332980001
    KING, Michael Henry
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    পরিচালক
    45 Leicester Road
    Wanstead
    E11 2DW London
    British14395670002
    KLAIRE, Clare Elizabeth
    1 Chalk Dell Cottages
    Chawton Park Road, Chawton
    GU34 1SW Alton
    Hampshire
    পরিচালক
    1 Chalk Dell Cottages
    Chawton Park Road, Chawton
    GU34 1SW Alton
    Hampshire
    United KingdomBritish75623670001
    MARLEY, Nicholas James
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    পরিচালক
    6 The Brambles
    Woodside
    SW19 7AY London
    United KingdomBritish113304050001
    MARLEY, Nicholas James
    2 Nursery Road
    Merton
    SW19 3BT London
    পরিচালক
    2 Nursery Road
    Merton
    SW19 3BT London
    British81585110001
    MORLEY, James
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Virginia House St Marys Road
    SL5 9JE Ascot
    Berkshire
    United KingdomUnited Kingdom13374700001
    MORLEY HAM, Stephen Richard
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    পরিচালক
    Golf Course Way
    Jolly Harbour
    St Mary's
    319b
    Antigua
    British80334700004
    MURPHY-COLES, Tobin Mathew
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    পরিচালক
    The Leadenhall Building
    122 Leadenhall Street
    EC3V 4AN London
    The Aon Centre
    United Kingdom
    EnglandBritish161141640001
    MURRAY, Alastair Neil
    B303, Gilbert Scott Building
    Scott Avenue
    SW15 3ST Putney
    পরিচালক
    B303, Gilbert Scott Building
    Scott Avenue
    SW15 3ST Putney
    United KingdomBritish124855970001
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    পরিচালক
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001
    NICHOL, Duncan Kirkbride, Sir
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    পরিচালক
    1 Pipers Close
    CH60 9LJ Heswall
    Merseyside
    United KingdomBritish85618250001

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৭ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for and on Behalf of the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ নভে, ২০০৮
    • ১৪ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the finance parties and/or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge all shares in any group company,all of its investments now or subsequently belonging to it held by an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse,London Branch
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ফেব, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০২ মার্চ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £15,862.50 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £15,862.50.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Amprop Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed equitable charge all the goodwill and uncalled capital the securities the insurances the rents the fixed plant and equipment by way of first floating charge all those assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mr Rar Francis, Mr Ajm Hutchins, Mr Po Jones
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ সেপ, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge the charged property to the chargee and upon an enforcement eventall dividends distributions, distributions in specie interest and other monies payable in respect of the charged property. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mr Rar Francis, Mr Ajm Hutchins, Mr Po Jones
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Charge over dividends and shares
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,296,450.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The charged shares , any shares or securities issued by way of redemption, bonus, rights, consolidation, sub-division, preference, option or otherwise in respect of the charged shares and all dividends, distributions and other monies payable in respect of charged shares.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Paul Brantingham
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over dividends and shares
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,296,450.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a fixed charge the shares and any shares or securities issued by way of redemption, bonus, rights, consolidation, sub-division, preference, option or otherwise in respect of the charged shares. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Paul Brantingham and Mark Brantingham
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rental deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £42,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Its interest in the deposit account (as defined in the deed) and all money withdrawn from the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Intel Corporation (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ডিসে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    AON CONSULTING (BENEFITS) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৬ সেপ, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৩ এপ্রি, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0