365 IT SUBCO NO.1 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নাম365 IT SUBCO NO.1 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04366702
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা কার্যক্রম (62090) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Napoleon House Riseley Business Park, Basingstoke Road
    Riseley
    RG7 1NW Reading
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    5I LIMITED০৫ ফেব, ২০০২০৫ ফেব, ২০০২

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    15 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১২ এপ্রি, ২০১২

    ১২ এপ্রি, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 120,762.69
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২২ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Maclean এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed 5I LIMITED\certificate issued on 01/12/11
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২৪ নভে, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Transfer share cap 22/09/2011
    RES13

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১০ থেকে ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    সচিব হিসাবে Mb Secretaries Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAUD

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01

    সচিব হিসাবে Alastair Ferguson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Alastair Ferguson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mr Alastair William Ferguson-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে David Hearn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে David Hearn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Alastair William Ferguson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    legacy

    5 পৃষ্ঠাMG01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    12 পৃষ্ঠাAR01

    ০৫ ফেব, ২০১০ তারিখে David Gareth Hearn-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MB SECRETARIES LIMITED
    The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    11
    Hampshire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর4813248
    124285230001
    ALLAN, Keith Andrew
    16 Sovereign Close
    CV8 1SQ Kenilworth
    Warwickshire
    পরিচালক
    16 Sovereign Close
    CV8 1SQ Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish100161360001
    BROWN, Richard William
    24a Alma Road
    SL4 3HL Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    24a Alma Road
    SL4 3HL Windsor
    Berkshire
    EnglandBritish100161150001
    HOWELLS, Peter Hugh
    Centurion House
    11 Romans Field,
    RG7 2QH Silchester
    Berkshire
    পরিচালক
    Centurion House
    11 Romans Field,
    RG7 2QH Silchester
    Berkshire
    EnglandBritish163030330001
    FERGUSON, Alastair William
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    সচিব
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    154526830001
    HEARN, David Gareth
    Middle Prospect New Road
    OX18 2LF Bampton
    Oxfordshire
    সচিব
    Middle Prospect New Road
    OX18 2LF Bampton
    Oxfordshire
    British59462210001
    ORCHARD, Clive
    Birchtree Cottages
    Kings Road Silchester
    RG7 2NT Reading
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Birchtree Cottages
    Kings Road Silchester
    RG7 2NT Reading
    2
    Berkshire
    United Kingdom
    British81052720003
    BOYES TURNER SECRETARIES LIMITED
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    কর্পোরেট সচিব
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    74407280002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FERGUSON, Alastair William
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    পরিচালক
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    EnglandBritish125179970001
    HEARN, David Gareth
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    পরিচালক
    Stroudley Road
    RG24 8FW Basingstoke
    4 Cartel Business Centre
    Hampshire
    United KingdomBritish59462210001
    MACLEAN, Peter
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    পরিচালক
    Steventon Manor
    RG25 3BE Steventon
    Hampshire
    United KingdomBritish157773140001
    ORCHARD, Clive
    47 Jubilee Close
    Pamber Heath
    RG26 3HP Tadley
    Hampshire
    পরিচালক
    47 Jubilee Close
    Pamber Heath
    RG26 3HP Tadley
    Hampshire
    British81052720002
    RANSOM, Graham Richard
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    UkBritish34690210001
    STEVENS, Terrence
    17 Elliott Rise
    SL5 8NN North Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    17 Elliott Rise
    SL5 8NN North Ascot
    Berkshire
    British81052700001
    BOYES TURNER DIRECTORS LIMITED
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    First Floor Abbots House
    Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    101374610001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    365 IT SUBCO NO.1 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০১০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account operated by field seymour parks as solicitors for the landlord under the lease pursuant to the terms of the said rent deposit deed.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mulhern Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Rbs Invoice Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies from time to time standing to the credit of the interest-bearing deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mulhern Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Venture Finance PLC Trading as Venture Factors
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rental deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies from time to time standing to the credit of the interest bearing deposit account pursuant to the terms of the rental deposit deed.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mulhern Properties Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £6,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £6,750.00.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Daceberry Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0