LONGLEAT PROPERTY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামLONGLEAT PROPERTY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04379589
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের রিয়েল এস্টেট ভাড়া এবং পরিচালনা (68201) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    One Edison Rise, New Ollerton
    Newark
    NG22 9DP Nottinghamshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ALNERY NO. 2254 LIMITED২২ ফেব, ২০০২২২ ফেব, ২০০২

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়২২ এপ্রি, ২০২৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়২২ জানু, ২০২৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে১৮ এপ্রি, ২০২৪

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২৫ মে, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে০৮ জুন, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে২৫ মে, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ১১ ফেব, ২০২৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.000000
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    6 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    6 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancel share premium 11/02/2025
    RES13

    ২২ নভে, ২০২৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.000000
    8 পৃষ্ঠাSH01

    second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date

    6 পৃষ্ঠাRP04CS01

    পূর্ণ হিসাব ১৮ এপ্রি, ২০২৪ পর্যন্ত তৈরি

    31 পৃষ্ঠাAA

    ২৫ মে, ২০২৪ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ১৭ মে, ২০২৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.000000
    4 পৃষ্ঠাSH01

    ০৫ আগ, ২০২৩ তারিখে Mr Andrea Colasanti-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ২০ এপ্রি, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    31 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    21 পৃষ্ঠাMA

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    ২৫ মে, ২০২৩ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১৭ সেপ, ২০২৪Clarification A second filed CS01 (statement of capital & shareholder information change) was registered on 17/09/2024.

    ১৪ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.000036
    8 পৃষ্ঠাSH01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ০৯ মে, ২০২৩Clarification due to system restrictions the correct aggregate value cannot be shown. Please refer to the document image for the correct value

    ২৪ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr James Bradley Hyler-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.000003
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    5 পৃষ্ঠাCAP-SS

    legacy

    5 পৃষ্ঠাSH20

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Cancelling share premium account 18/04/2023
    RES13

    ১৪ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Zachary Bryan Vaughan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২১ ফেব, ২০২৩ তারিখে Rajbinder Singh-Dehal-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ১২ ডিসে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Katrina Jamieson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ২১ এপ্রি, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    31 পৃষ্ঠাAA

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SINGH-DEHAL, Rajbinder
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    সচিব
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Other138962680001
    ANNABLE, Benedict Tobias, Mr.
    Level 25
    Canary Wharf
    E14 5AA London
    One Canada Square
    United Kingdom
    পরিচালক
    Level 25
    Canary Wharf
    E14 5AA London
    One Canada Square
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector228970180002
    COLASANTI, Andrea, Mr.
    Canada Square
    Level 25 Canary Wharf
    E14 5AA London
    One
    United Kingdom
    পরিচালক
    Canada Square
    Level 25 Canary Wharf
    E14 5AA London
    One
    United Kingdom
    United KingdomItalianDirector279066390002
    HYLER, James Bradley
    Level 25
    Canary Wharf
    E14 5AA London
    One Canada Square
    United Kingdom
    পরিচালক
    Level 25
    Canary Wharf
    E14 5AA London
    One Canada Square
    United Kingdom
    EnglandAmericanDirector202532610002
    JAMIESON, Katrina
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector303839060001
    MCKINLAY, Colin Grant
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector156396250025
    BRADSHAW, Andrew Philip
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    সচিব
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    British114356940001
    CUMMINS, Diarmuid
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    সচিব
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    BritishDirector78791890003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    সচিব
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    সচিব
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    সচিব
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    BritishChartered Secretary138694570001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    সচিব
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United StatesDirector107030970001
    WILSON, Christopher
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    সচিব
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    BritishBanker103272700001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ADOMAIT, Natalie Johanna
    1 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AA London
    Level 25
    United Kingdom
    পরিচালক
    1 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AA London
    Level 25
    United Kingdom
    United KingdomCanadianDirector221376510014
    ANEJA, Vikram
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Notts
    United Kingdom
    পরিচালক
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Notts
    United Kingdom
    EnglandCanadianDirector205778000001
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    OtherDirector94259330004
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    OtherDirector94259330004
    BURYCH, Andrew
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomCanadianDirector199966440001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    পরিচালক
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    BritishChartered Accountant98778780002
    CUMMINS, Diarmuid
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Westfieldbury
    Westland Green
    SG11 2AL Little Hadham
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector78791890003
    DALBY, Martin Peter
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector83381250004
    DE'ATH, Andrew John
    Warren Road
    Staverton
    BA14 8UZ Trowbridge
    20
    Wiltshire
    পরিচালক
    Warren Road
    Staverton
    BA14 8UZ Trowbridge
    20
    Wiltshire
    EnglandBritishGeneral Manager117819740001
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    পরিচালক
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritishBanker76313640003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    পরিচালক
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritishDirector50060390001
    HAWKES, Edward Jonathan Cameron
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    পরিচালক
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    United KingdomBritishDirector93239900002
    HOULIHAN, Susan
    70 Frankland Close
    BA1 4EL Bath
    পরিচালক
    70 Frankland Close
    BA1 4EL Bath
    BritishDeputy General Manager123848920001
    INGLETT, Paul
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector81617110003
    JONAS, Marc Nicholas
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    পরিচালক
    Flat 2
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    EnglandBritishCorporate Financier55841850004
    LEAVOR, Judi Elizabeth
    Woodlands 2 Estcourt Drive
    Darrington
    WF8 3BN Pontefract
    Yorkshire
    পরিচালক
    Woodlands 2 Estcourt Drive
    Darrington
    WF8 3BN Pontefract
    Yorkshire
    BritishHuman Resources Director93111380001
    MAWJI-KARIM, Farhad
    Pembridge Square
    W2 4EW London
    3
    England
    England
    পরিচালক
    Pembridge Square
    W2 4EW London
    3
    England
    England
    United KingdomBritishDirector166000930001
    MCCRAIN, Kevin O'Donnell
    1 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AA London
    Level 25
    United Kingdom
    পরিচালক
    1 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5AA London
    Level 25
    United Kingdom
    EnglandAmericanDirector195429180003
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    পরিচালক
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    BritishDirector46361590002
    MOAKES, Kerry, Mr
    Monas Cottage
    Witham Road, Long Bennington
    NG23 5DS Newark
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Monas Cottage
    Witham Road, Long Bennington
    NG23 5DS Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishIt Manager123848960001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    পরিচালক
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    BritishBank Employee98781970001

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশUnited Kingdom
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর07656396
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    LONGLEAT PROPERTY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Borrower deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Borrower Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Securitisation floating charge debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Trust Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Intercreditor deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুল, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Trust Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুল, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Intercreditor deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company has undertaken to the instructing agent that if an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any party of the unsecured debt; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the unsecured debt, subject to the intercreditor deed by way of payment repayment prepayment setoff netting or in any other manner or on account of the enforcement of any security document or payment under any guarantee for any of the secured debt, in each case the company shall hold the same on trust for the instructing agent and promptly pay the same and promptly pay an amount equal to that amount so discharged,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Trust Company Limited as Security Trustee for the Secured Creditors
    ব্যবসায়
    • ২৮ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Trust Company Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a center parcs holiday village, horningsham road, longleat, warminster t/no WT190379 and aucombe house, longleat wiltshire t/no WT190379 and any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Trust Company Limited as Trustee for Each of the Finance Parties (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ১৫ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0