NORD UK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNORD UK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04411175
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NORD UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য শিক্ষা ন.এ.সি. (85590) / শিক্ষা

    NORD UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    No 1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NORD UK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    LEAPFROG DAY NURSERIES LIMITED০৯ জুন, ২০০৪০৯ জুন, ২০০৪
    LEAPFROG DAY NURSERIES PLC০২ মে, ২০০২০২ মে, ২০০২
    FUNQUEST PLC০৮ এপ্রি, ২০০২০৮ এপ্রি, ২০০২

    NORD UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ আগ, ২০১১

    NORD UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    9 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২০ জুল, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ অক্টো, ২০১১

    ২০ অক্টো, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 17,827,803.8
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Graeme Robert Halder-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে David Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে David Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ আগ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ২৯ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Andrew Fitzmaurice-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ আগ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    18 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    NORD UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    FITZMAURICE, Andrew
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    পরিচালক
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    EnglandBritish70922490002
    HALDER, Graeme Robert
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    পরিচালক
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    No 1
    Hampshire
    Hong Kong, ChinaBritish154739000001
    BUTCHER, Michael Leonard
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    সচিব
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    British43307770001
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    সচিব
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British73116190002
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    সচিব
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British73116190002
    MEAD, Richard Barwick
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    সচিব
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    British44255220002
    METCALF, Hannah Ruth
    Addleshaw Goddard
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Lancashire
    সচিব
    Addleshaw Goddard
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Lancashire
    British114415480001
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    সচিব
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    British51283590002
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    সচিব
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    British124619670001
    TARN, Elizabeth Jill
    Flat 10 Rosemount House
    15a Poplar Road Dorridge
    B93 8DD Solihull
    সচিব
    Flat 10 Rosemount House
    15a Poplar Road Dorridge
    B93 8DD Solihull
    British92051440005
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    BUTCHER, Michael Leonard
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    পরিচালক
    13 Hecadeck Lane
    Nether Broughton
    LE14 3EZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    British43307770001
    HAWKINS, Ian Roger
    The Old Colley Farm
    Coppice Lane
    RH2 9JE Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    The Old Colley Farm
    Coppice Lane
    RH2 9JE Reigate
    Surrey
    British15991450002
    HUSBANDS, Susan Dawn
    Severn Cottage 24 Buildwas Road
    Ironbridge
    TF8 7DW Telford
    Salop
    পরিচালক
    Severn Cottage 24 Buildwas Road
    Ironbridge
    TF8 7DW Telford
    Salop
    British57874840001
    HYDE, Stephen
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    পরিচালক
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British73116190002
    MAPP, Derek
    Sudbrook Hall
    Nesfield, Barlow
    S18 7TB Dronfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    Sudbrook Hall
    Nesfield, Barlow
    S18 7TB Dronfield
    Derbyshire
    United KingdomBritish12473610002
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    পরিচালক
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    British87585160002
    MCNEANY, Kevin Joseph
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    EnglandIrish2299150001
    MEAD, Richard Barwick
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Clayfurlong House
    Kemble
    GL7 6BS Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish44255220002
    NOTT, Gillian
    3 St Peters Square
    W6 9AB London
    পরিচালক
    3 St Peters Square
    W6 9AB London
    EnglandBritish37051540002
    ROBINSON, Clive William
    16 Chislehurst Road
    TW10 6PW Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    16 Chislehurst Road
    TW10 6PW Richmond
    Surrey
    EnglandBritish13438180002
    SELVEY, Anthony Rochford
    14 Monterey Close
    DA5 2BX Bexley
    Kent
    পরিচালক
    14 Monterey Close
    DA5 2BX Bexley
    Kent
    British6037980001
    SIMPSON, Lorene
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    182 Bramhall Lane South
    Bramhall
    SK7 2PR Stockport
    Cheshire
    British51283590002
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish124619670001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    কর্পোরেট পরিচালক
    280 Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    77390740003
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    900023400001

    NORD UK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Suisse, Singapore Branch (As Security Agent for the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Aib Group (UK) PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুন, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুন, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ জুন, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ জুন, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ জুল, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of accession to a composite guarantee and debentur e dated 1 april 1998
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies from time to time owing due or to become due from the charging companies to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (the "security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    NORD UK LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২০ জুল, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৩ অক্টো, ২০১৩ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0