COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCOLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04414667
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SYDNEY & BIRMINGHAM 2 LIMITED১১ এপ্রি, ২০০২১১ এপ্রি, ২০০২

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৫

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    43 পৃষ্ঠা4.71

    ২৪ ফেব, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neil Kenneth Robertson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১১ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU থেকে The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SGপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২২ মার্চ, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 6 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    ০৫ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Claire Treacy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৫ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Neil Kenneth Robertson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৪ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Claire Treacy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৪ আগ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Fraser James Kennedy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ এপ্রি, ২০১৫

    ১৭ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ এপ্রি, ২০১৪

    ১৬ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    ০১ জুল, ২০১৩ তারিখে Valsec Director Limited-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH02

    ০১ জুল, ২০১৩ তারিখে Mr Fraser James Kennedy-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ১১ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বরSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর5307786
    102622300002
    CURTIS, Wendy June
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    সচিব
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    British46982690003
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    সচিব
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    CHALFEN SECRETARIES LIMITED
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    900013320001
    ANNING, Richard John
    Witchwood
    Westra
    CF64 4HA Dinas Powys
    Vale Of Glamorgan
    পরিচালক
    Witchwood
    Westra
    CF64 4HA Dinas Powys
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritish14073020003
    CHILDS, Simon John
    18 Hardwicke Court
    Llandaff
    CF5 2LB Cardiff
    পরিচালক
    18 Hardwicke Court
    Llandaff
    CF5 2LB Cardiff
    WalesBritish78425720001
    CURTIS, Wendy June
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    পরিচালক
    136 Henke Court
    Schooner Way Atlantic Wharf
    CF10 4EL Cardiff
    British46982690003
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    পরিচালক
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    পরিচালক
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    পরিচালক
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish135717740001
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    পরিচালক
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    পরিচালক
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    পরিচালক
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    পরিচালক
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    CHALFEN NOMINEES LIMITED
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    3rd Floor
    19 Phipp Street
    EC2A 4NP London
    900013310001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land to the north east of old park road wednesbury t/no WM398013 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ৩০ মার্চ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১২ জানু, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of accession and charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জানু, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জানু, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h and l/h property k/a all saints business park all saints road wednesbury west midlands WS10 9TS t/nos WM398013 and WM695818. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জানু, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Supplemental deed (supplemental to a deed dated 18 august 1998)
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage the charged properties together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জুল, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any group member to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge the shares. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জুল, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০০২
    অর্জিত হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a all saints road wednesbury t/n WM695818 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ এপ্রি, ২০০২অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ৩১ জুল, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    COLERIDGE (WEDNESBURY 2) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২২ মার্চ, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ৩০ জুল, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    অভ্যাসকারী
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    অভ্যাসকারী
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0