CAMERA MEZZ LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCAMERA MEZZ LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04421871
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CAMERA MEZZ LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    CAMERA MEZZ LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Leicestershire
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CAMERA MEZZ LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JESSOPS LIMITED১০ ডিসে, ২০০৩১০ ডিসে, ২০০৩
    CAMERA MEZZ LIMITED২১ আগ, ২০০২২১ আগ, ২০০২
    INTERCEDE 1783 LIMITED২২ এপ্রি, ২০০২২২ এপ্রি, ২০০২

    CAMERA MEZZ LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    CAMERA MEZZ LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CAMERA MEZZ LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    উইন্ডিং আপের সমাপ্তি

    1 পৃষ্ঠাL64.07

    আদালতের আদেশ উইন্ডিং আপের জন্য

    2 পৃষ্ঠাCOCOMP

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১২ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ জুন, ২০১২

    ০১ জুন, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 70,437
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    সচিব হিসাবে Nicholas Molyneux এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Mr Chris Yates-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Hannan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Sean Emmett-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Ms Joanna Boydell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে David Cashman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Hannan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে William Rollason এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr David Cashman-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ২২ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ নভে, ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    CAMERA MEZZ LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BOYDELL, Joanna
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164373820001
    EMMETT, Sean Robert
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152701300001
    YATES, Chris Paul
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Jessop House
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish152699330001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    সচিব
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    British48224770001
    MOLYNEUX, Nicholas John
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    সচিব
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    British93529300001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    CASHMAN, David
    Jessop House
    Scudmore Road
    LE3 1TZ Leicester
    পরিচালক
    Jessop House
    Scudmore Road
    LE3 1TZ Leicester
    EnglandBritish152688720001
    CRABTREE, John Nigel
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    পরিচালক
    37 Redlake Drive
    Pedmore
    DY9 0RX Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritish48224770001
    GIDDINGS, Michael John
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    British105128310002
    HANNAN, Andrew
    Jessop House
    Scudmore Road
    LE3 1TZ Leicester
    পরিচালক
    Jessop House
    Scudmore Road
    LE3 1TZ Leicester
    EnglandBritish153976980001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116885790001
    HINE, Derek Leslie
    Red Lion Witley Road
    Holt Heath
    WR6 6LX Worcester
    পরিচালক
    Red Lion Witley Road
    Holt Heath
    WR6 6LX Worcester
    United KingdomBritish61935280001
    REDPATH, James
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123915050001
    ROLLASON, William Peter
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    পরিচালক
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritish67354680003
    MITRE DIRECTORS LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900024450001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    কর্পোরেট পরিচালক
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001

    CAMERA MEZZ LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Composite debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৭ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ মে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ মে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ মে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ সেপ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Investment Bank PLC (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ মে, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CAMERA MEZZ LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১১ জুন, ২০১৪ভেঙে গেছে
    ০১ জুল, ২০১৩ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৫ মার্চ, ২০১৪ওয়াইন্ডিং আপ শেষ
    ১৫ মে, ২০১৩আবেদন তারিখ
    বাধ্যতামূলক তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    The Official Receiver Or Leicester
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester
    অভ্যাসকারী
    4th Floor
    Wellington House
    LE1 6HL Wellington Street
    Leicester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0