METNOR EBT LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMETNOR EBT LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04432142
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    METNOR EBT LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    METNOR EBT LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Metnor House
    Mylord Crescent
    NE12 5YD Killingworth
    Newcastle Upon Tyne
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    METNOR EBT LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    GATEWAY PARK LIMITED০৬ আগ, ২০০২০৬ আগ, ২০০২
    COBCO (455) LIMITED০৭ মে, ২০০২০৭ মে, ২০০২

    METNOR EBT LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    METNOR EBT LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ জুল, ২০১৩

    ০১ জুল, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ১৮ মে, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kim Rankin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed gateway park LIMITED\certificate issued on 28/09/10
    1 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২০ সেপ, ২০১০

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    সচিব হিসাবে Mrs Sarah Atkinson-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Keith Atkinson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Mr Keith Andrew Atkinson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Stephen Rankin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ২৮ জুন, ২০১০ তারিখে Mrs Kim Rankin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    METNOR EBT LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ATKINSON, Sarah
    Metnor House
    Mylord Crescent
    NE12 5YD Killingworth
    Newcastle Upon Tyne
    সচিব
    Metnor House
    Mylord Crescent
    NE12 5YD Killingworth
    Newcastle Upon Tyne
    154340490001
    ATKINSON, Keith Andrew
    Metnor House
    Mylord Crescent
    NE12 5YD Killingworth
    Newcastle Upon Tyne
    পরিচালক
    Metnor House
    Mylord Crescent
    NE12 5YD Killingworth
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishAccountant36184740003
    ATKINSON, Keith Andrew
    10 Easby Close
    NE3 5LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    সচিব
    10 Easby Close
    NE3 5LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishAccountant36184740003
    CLARK, Andrew David
    101 Bower Road
    Crookes
    S10 1ER Sheffield
    South Yorkshire
    সচিব
    101 Bower Road
    Crookes
    S10 1ER Sheffield
    South Yorkshire
    BritishAccountant73828660001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    কর্পোরেট সচিব
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ATKINSON, Keith Andrew
    10 Easby Close
    NE3 5LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    10 Easby Close
    NE3 5LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector36184740003
    CLARK, Andrew David
    101 Bower Road
    Crookes
    S10 1ER Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    101 Bower Road
    Crookes
    S10 1ER Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishAccountant73828660001
    PARKINSON, Eric John Keith
    3 Coniscliffe Mews
    DL3 8UZ Darlington
    County Durham
    পরিচালক
    3 Coniscliffe Mews
    DL3 8UZ Darlington
    County Durham
    EnglandBritishDirector26252370003
    RANKIN, Kim
    74 Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    74 Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishCompany Director63318510002
    RANKIN, Stephen
    74 Runnymede Road
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    74 Runnymede Road
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9HH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector59400760003
    WOOD, John Gibbon
    Cliffe Cottage The Green
    Washington Village
    NE38 7AB Washington
    Tyne & Wear
    পরিচালক
    Cliffe Cottage The Green
    Washington Village
    NE38 7AB Washington
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCivil Servant7692600001
    COBBETTS LIMITED
    Ship Canal House King Street
    M2 4WB Manchester
    কর্পোরেট পরিচালক
    Ship Canal House King Street
    M2 4WB Manchester
    43263300002

    METNOR EBT LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over construction documents
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge all the company's right, title, benefit and interest (present and future) in a building contract between the company any tolent construction limited dated 15TH november 2004. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Charge over pre sale agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge all the company's right, title, benefit and interest (present and future) in the pre sale agreement together with all rights for the company to sue or take action in respect of any obligations containing in such documents.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a new chester road/ old hall road/ bromborough, the wirral t/no MS466834. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H carillion property new chester road and old hall road bromborough wirral all f/h and l/h land, plant and machinery, goodwill & uncalled capital, stocks and shares, intellectual property and insurance floating charge all other assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mentor Group PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0