EDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামEDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04442455
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    EDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7487) /

    EDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    321 Bradford Street
    B5 6ET Birmingham
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    EDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DBK GOYNE ADAMS LIMITED১৩ এপ্রি, ২০০৭১৩ এপ্রি, ২০০৭
    GOYNE ADAMS LIMITED২০ মে, ২০০২২০ মে, ২০০২

    EDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১০

    EDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৮ জুল, ২০১১

    ০৮ জুল, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,226
    SH01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed dbk goyne adams LIMITED\certificate issued on 30/03/11
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name৩০ মার্চ, ২০১১

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৮ মার্চ, ২০১১

    RES15

    মোট ছাড় পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Jonathan Addis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২০ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ২০ মে, ২০১০ তারিখে Timothy James Downing-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ২৯ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    resolution

    নির্বাচনী প্রস্তাব

    ELRES

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    resolution

    নির্বাচনী প্রস্তাব

    ELRES

    EDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MASSEY, Andrew Joseph
    Ranikhet
    Wenlock Road
    WV16 5AZ Bridgnorth
    Shropshire
    সচিব
    Ranikhet
    Wenlock Road
    WV16 5AZ Bridgnorth
    Shropshire
    British62344120004
    BERRY, Duncan Steven
    28 Oakham Road
    Harborne
    B17 9DG Birmingham
    West Midlands
    পরিচালক
    28 Oakham Road
    Harborne
    B17 9DG Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishDirector115331950001
    DOWNING, Timothy James
    The Cruck Barn
    Lower House Farm Chetton
    WV18 6UF Bridgnorth
    West Midlands
    পরিচালক
    The Cruck Barn
    Lower House Farm Chetton
    WV18 6UF Bridgnorth
    West Midlands
    EnglandBritishDirector120596020001
    KELLY, Steven Paul
    Middle Mill
    Stratford Road Wooton Wawen
    B95 6BY Henley In Arden
    Warwickshire
    পরিচালক
    Middle Mill
    Stratford Road Wooton Wawen
    B95 6BY Henley In Arden
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector94587020002
    KENNEDY, Andrew Martin
    The Folly
    Hurn Court Hurn
    BH23 6BH Christchurch
    Dorset
    England
    সচিব
    The Folly
    Hurn Court Hurn
    BH23 6BH Christchurch
    Dorset
    England
    BritishQuantity Surveyor51174310001
    RWL REGISTRARS LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    900007870001
    ADAMS, Roger William
    60 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    পরিচালক
    60 Golf Links Road
    BH22 8BZ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishQuantity Surveyor49690040001
    ADDIS, Jonathan Peter
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    পরিচালক
    Park Hill
    B13 8DS Birmingham
    98
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Finance Director260439420001
    BALHARRIE, Gordon Alexander
    23 Waverley Avenue
    Berrylands
    KT5 9HD Surbiton
    Surrey
    পরিচালক
    23 Waverley Avenue
    Berrylands
    KT5 9HD Surbiton
    Surrey
    United KingdomBritishQuantity Surveyor158788510001
    DRONSFIELD, Jonathan
    8 Excelsior Road
    BH14 TT Poole
    পরিচালক
    8 Excelsior Road
    BH14 TT Poole
    EnglandBritishBuilding Surveying121643540001
    DUFF, Christopher
    17 Navigators Way
    SO30 2GP Hedge End
    Hampshire
    পরিচালক
    17 Navigators Way
    SO30 2GP Hedge End
    Hampshire
    BritishSurveyor98970710001
    JAGROOP, Michael-Paul
    10 Second Avenue
    Queens Park
    W10 4RW London
    পরিচালক
    10 Second Avenue
    Queens Park
    W10 4RW London
    BritishBuilding Surveyor106240160001
    KENNEDY, Andrew Martin
    The Folly
    Hurn Court Hurn
    BH23 6BH Christchurch
    Dorset
    England
    পরিচালক
    The Folly
    Hurn Court Hurn
    BH23 6BH Christchurch
    Dorset
    England
    United KingdomBritishQuantity Surveyor51174310001
    MUFFETT, Richard John
    Prides Cottage
    High Street
    DT11 8EH Child Okeford
    Dorset
    পরিচালক
    Prides Cottage
    High Street
    DT11 8EH Child Okeford
    Dorset
    BritishQuantity Surveying98812910001
    SMITH, Derek Gordon
    12 Sheepfold
    St Ives
    PE17 4FY Huntingdon
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    12 Sheepfold
    St Ives
    PE17 4FY Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishQuantity Surveying30853730001
    BONUSWORTH LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    900006860001

    EDMONTON GOYNE ADAMS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৭ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Rent deposit in the sum of £7,965.00 plus an amount equivalent to vat thereon held by the chargee and the interest thereon or other sums deposited in the rental deposit account.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Collin Estates Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0