SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04502016
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য মানব স্বাস্থ্য কার্যক্রম (86900) / মানব স্বাস্থ্য এবং সামাজিক কাজ কার্যক্রম

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HIGHFIELD HEALTHCARE CENTRES LIMITED২৩ অক্টো, ২০০২২৩ অক্টো, ২০০২
    SOUTHWEST LIMITED০২ আগ, ২০০২০২ আগ, ২০০২

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১০

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৯ অক্টো, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Francis Declan Finbar Tempany Mccormack এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সমাপ্তির নোটিশ

    6 পৃষ্ঠা1.4

    ১৭ আগ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Timothy James Bolot এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ আগ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ আগ, ২০১২

    ১৪ আগ, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 600,002
    SH01

    রেজিস্ট্রারকে নোটিশ কোম্পানির স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার কার্যকরী

    4 পৃষ্ঠা1.1

    ১৫ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে William James Buchan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ নভে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Andrew Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephen Jonathan Taylor-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৬ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Timothy James Bolot-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    28 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    সচিব হিসাবে William Mcleish এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    সচিব হিসাবে Francis Declan Finbar Tempany Mccormack-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে Richard Midmer এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Explanatory statment to sole member 14/05/2010
    RES13

    পূর্ণ হিসাব ২৭ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    25 পৃষ্ঠাAA

    ০৭ জানু, ২০১০ তারিখে Mr David Andrew Smith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Mr David Andrew Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে David Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mr David Andrew Smith-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Kamma Foulkes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    সচিব
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    সচিব
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    সচিব
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305970001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    সচিব
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    ASARIA, Mohamed Saleem
    Fringewood Close
    HA6 2TB Northwood
    8
    Middlesex
    পরিচালক
    Fringewood Close
    HA6 2TB Northwood
    8
    Middlesex
    EnglandBritish13927880001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    পরিচালক
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    পরিচালক
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GROOMBRIDGE, Kevin John
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    পরিচালক
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    EnglandBritish105722880001
    JOYCE, Martin Patrick
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    পরিচালক
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    United KingdomBritish27130160009
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    পরিচালক
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    পরিচালক
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    পরিচালক
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MCQUAID, Michael James
    Baily Bach
    Cobham Way
    KT24 5BH East Horsley
    Surrey
    পরিচালক
    Baily Bach
    Cobham Way
    KT24 5BH East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish89052830001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    পরিচালক
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    পরিচালক
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    পরিচালক
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    পরিচালক
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    পরিচালক
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    পরিচালক
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    পরিচালক
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    পরিচালক
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STEIN, Anthony Karl
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    পরিচালক
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    United KingdomBritish109518530001
    WILSON, Mark Stephen
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    পরিচালক
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    British90893350001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit; the interest; the deposit account and the deposit balance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No.5 Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold premises situate at the limes nursing home main street whaley thorns nether langwith mansfield nottinghamshire NG20 9HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১০ মে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit the interest the deposit account and the deposit balance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No.10 Limited
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit, all interest, the deposit account being an interest bearing account specifically designated "regis house nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum of £10,080. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H premises at beech tree house 120-122 himley road dudley west midlands DY1 2QQ. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No.10 Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H premises at regis house nursing home 29 causeway blackheath rowley regis warley west midlands B65 8AA. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No.10 Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit being the sum of £39,348 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "woodcross mental care centre deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H premises situate at woodcross mental care centre 23 reeves street bloxwich walsall west midlands WS3 2DG. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No.5 Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No.3 Limited
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৮ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The l/h property k/a woodcross house nursing home (sedgley) woodcross street, woodcross, wolverhampton, WV14 9RT. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১০ মে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Nhp Securities No.5 Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২০ জুন, ২০১২সিভিএ অনুমোদনের সভার তারিখ
    ২০ আগ, ২০১২সিভিএ সম্পন্ন বা সমাপ্তির তারিখ
    কর্পোরেট স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা (সিভিএ)
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    অভ্যাসকারী
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0