SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04556634
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের রিয়েল এস্টেট ভাড়া এবং পরিচালনা (68201) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Sanctuary House, Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HEALTHCARE PROPERTIES (OXFORD) LIMITED০৮ অক্টো, ২০০২০৮ অক্টো, ২০০২

    SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১৯

    SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    2 পৃষ্ঠাDS01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    31 পৃষ্ঠাMA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    ০৬ অক্টো, ২০২০ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ১৪ আগ, ২০২০ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Sanctuary Care (R) Scotland Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ অক্টো, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৫ সেপ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Anthony Neil King এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২২ মে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Edward Henry Lunt-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ জানু, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Craig Jon Moule এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Peter John Williams-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ অক্টো, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    Nicole Seymour কে সচিব হিসাবে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    6 পৃষ্ঠাRP04AP03

    Craig Moule কে সচিব হিসাবে অবসানের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    5 পৃষ্ঠাRP04TM02

    ২৫ মে, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Craig Jon Moule এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১২ জুল, ২০১৮Clarification A second filed TM02 was registered on 12/07/2018.

    ২৫ মে, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mrs Nicole Seymour-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ১২ জুল, ২০১৮Clarification A second filed AP03 was registered on 12/07/2018.

    ২৫ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Embrace Realty Scotland Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name২৮ মার্চ, ২০১৮

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ২২ মার্চ, ২০১৮

    RES15

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩০ জুন, ২০১৮ থেকে ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ১৭ নভে, ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে Sophie Atkinson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SEYMOUR, Nicole
    Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ
    Sanctuary House
    Worcester
    England
    সচিব
    Chamber Court
    Castle Street
    WR1 3ZQ
    Sanctuary House
    Worcester
    England
    246823620001
    LUNT, Edward Henry
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    পরিচালক
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    EnglandBritishDirector258777900001
    WARREN, Nathan Lee
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    পরিচালক
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    United KingdomBritishDirector130959110002
    WHITMORE, James Robert
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    পরিচালক
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    EnglandBritishDirector209804070001
    WILLIAMS, Peter John
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    পরিচালক
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    EnglandBritishDirector163514920001
    ATKINSON, Sophie
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    সচিব
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    234520120001
    BENEY, Ralph Martin
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    সচিব
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    BritishDirector Secretary85286690001
    BORG, Richard Joseph
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NP Welwyn
    Fulling Mill House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NP Welwyn
    Fulling Mill House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    BritishSolicitor121685170001
    KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    সচিব
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    England
    British171438080001
    MOULE, Craig Jon
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    সচিব
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    240636540001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    BENEY, Ralph Martin
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    পরিচালক
    August Pitts Farmhouse
    Churn Lane
    TN12 8HW Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishDirector85286690001
    BORG, Richard Joseph
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NP Welwyn
    Fulling Mill House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Fulling Mill Lane
    AL6 9NP Welwyn
    Fulling Mill House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director147791080001
    KING, Anthony Neil
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    পরিচালক
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    EnglandBritishDirector9255540009
    LANFRANCONI, Victor Giuseppe, Dr
    Casa Galli
    Gerra Gamb
    Tricino 6576
    Switzerland
    পরিচালক
    Casa Galli
    Gerra Gamb
    Tricino 6576
    Switzerland
    SwissDirector85544890001
    LEE, Patricia Lesley
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    পরিচালক
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    United KingdomBritishChief Executive192233540001
    MANSON, David Lindsay
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    পরিচালক
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    United KingdomBritishNone170602970001
    MOULE, Craig Jon
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    পরিচালক
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Sanctuary House, Chamber Court
    England
    EnglandBritishDirector135984850005
    SMITH, Albert Edward
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    United Kingdom
    পরিচালক
    c/o Part Ground & First Floor
    Great Park
    Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    Two Parklands
    United Kingdom
    EnglandBritishNone77631340001
    SRINIVAS, Doraiswamy, Doctor
    63 Ashley Gardens
    SW1P 1QG Ambrosden Avenue
    London
    পরিচালক
    63 Ashley Gardens
    SW1P 1QG Ambrosden Avenue
    London
    United KingdomAmerican,BritishDirector85286410001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    280 Grays Inn Road
    WC1X 8EB London
    900023400001

    SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Sanctuary Care (North) Limited
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act
    নিবন্ধিত স্থানEngland
    নিবন্ধন নম্বর08991220
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    SANCTUARY CARE (CP OXFORD) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ আগ, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a grosvenor lodge grosvenor road south shields t/no TY53967 and f/h property k/a howard's castle care centre dacre street morpeth t/no's ND11141 and ND90100. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ০৬ সেপ, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১০ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of accession and charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুল, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ আগ, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 26 grosvenor road south shields tyne & wear t/no TY53967, dacre street morpeth northumberland t/nos ND11141 and ND90100 and kibblesworth gatehead tyne & wear t/no TY206161 for details of further property charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ০৩ আগ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১০ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the right title benefit and interest in and to each and every assigned contract meaning the rights and interests under the agreements described in the schedule 1. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ মে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The properties being, howard castle nursing home, dacre place, morpeth. T/no's ND90100 and ND11141. Pickering lodge nursing home, pickering nook, stanley, durham. T/no DU151301. Meadow view specialist residential care home, front street, kibblesworth, gateshead. TY206161. For details of further properties charged please refer to form 395. by way of fixed charge all buildings and other structures on and items fixed to the properties, any goodwill relating to the property, all plant, machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ মে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of charge security over shares
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the securities and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture containing fixed and floating charges
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the. Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Healthcare Properties (Ashlea) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property situate and k/a manor house nursing home merton bicester oxon OX25 2NF.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Healthcare Properties (Ashlea) Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold land and buildings situate at and known as manor house nursing home merton bicester title number ON214669. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0