AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামAGORA SHOPPING CENTRES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04582001
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TINKERFROST LIMITED০৫ নভে, ২০০২০৫ নভে, ২০০২

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১১

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ০৩ অক্টো, ২০১৭ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাRM02

    legacy

    পৃষ্ঠাLQ01

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাRM02

    ১০ জানু, ২০১৭ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    ১০ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    ১০ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    প্রশাসনিক রিসিভারের প্রতিবেদন

    18 পৃষ্ঠা3.10

    ১০ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাLQ01

    পরিচালক হিসাবে Neil Burnett এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    15 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ জানু, ২০১৩

    ১৬ জানু, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 14,646,026
    SH01

    সচিব হিসাবে Robert Corry এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    সচিব হিসাবে Heather Curtis-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে David Lanchester এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Robert Game এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Mark Keogh এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Philip Warner এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    পরিচালক হিসাবে David Edward Brown-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CURTIS, Heather
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    সচিব
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    British171899400001
    BROWN, David Edward
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    পরিচালক
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritishProperty Asset Manager78731890002
    CORRY, Robert John
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    সচিব
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    British171582190001
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    সচিব
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BELL, Simon Harold
    Ravelston Dykes
    EH4 3JE Edinburgh
    17
    পরিচালক
    Ravelston Dykes
    EH4 3JE Edinburgh
    17
    BritishBanker128941230001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    পরিচালক
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    BritishBanker122926460001
    BURNETT, Neil Scott
    Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    1
    Scotland
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    1
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director93937250003
    BURNETT, Neil Scott
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    পরিচালক
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    BritishInvestment Manager93937250001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant26086560001
    DICKSON, Pamela Simone
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    পরিচালক
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    United KingdomScottishBanker91810830001
    EDWARDS, David Lindsey
    4 Rosebury Drive
    Bisley
    GU24 9RX Woking
    Surrey
    পরিচালক
    4 Rosebury Drive
    Bisley
    GU24 9RX Woking
    Surrey
    BritishChartered Accountant53245050002
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    পরিচালক
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United KingdomEnglishChartered Surveyor139555050001
    HEPBURN, Alastair John Harley
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishBanker114477450001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    পরিচালক
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritishBanker113081830001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    পরিচালক
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrishChartered Accountant62140690001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    পরিচালক
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrishChartered Accountant62140690001
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    পরিচালক
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    United KingdomBritishChartered Secretary7014460002
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    মনোনীত পরিচালক
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MACDONALD, Gary
    23 Hillview Drive
    EH12 8QP Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    23 Hillview Drive
    EH12 8QP Edinburgh
    Midlothian
    BritishBanker127023890001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishProperty Investment Director73793650001
    MUNRO, Robert Alexander
    Plumley House,122 Bradbourne Road
    TN13 3QP Sevenoaks
    Kent
    পরিচালক
    Plumley House,122 Bradbourne Road
    TN13 3QP Sevenoaks
    Kent
    BritishBanker74429120001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    মনোনীত পরিচালক
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SMALLWOOD, James Douglas Mortimer
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director110517930001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor60348780002
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor60348780002
    STRACHAN, Philip David
    68 St John's Road
    BR5 1HY Orpington
    Kent
    পরিচালক
    68 St John's Road
    BR5 1HY Orpington
    Kent
    BritishBanker96666000001
    TAYLOR, David Hunter
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    পরিচালক
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    BritishBanker70908350001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    পরিচালক
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritishAccountant5689250001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    পরিচালক
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    United KingdomBritishCompany Chief Executive7356840002
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    পরিচালক
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Chief Executive7356840001

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H market place shopping centre bolton t/no GM485110,f/h 38 and 40 market street,16A,18,20,22,24 and 26 corporation street and 1 lorne street bolton t/no GM36285,f/h 28 and 30 corporation street bolton t/no's GM99081 and GM14797 (for details of further properties charged please refer to form 395) fixed charge all buildings and other structures,any goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Truste for Itself and Each of the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১৮ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any a finance party or any b finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The properties being f/h cavern walks, liverpoole, marina walk being land on the south side of mathew street liverpool t/n MS422649. F/h and l/h fishergate preston t/nos LA724316, LA728630, LA774760 and LA612623. (For details of further pro. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১২ এপ্রি, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security interest
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights title and interest in and to the shares all dividends interest and other income in respect of the said shares. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Each of the a Financeparties and Each of the B Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১৮ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any a finance party or any b finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • 1১৭ জানু, ২০১৩একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (LQ01)
    • 1০৪ অক্টো, ২০১৭একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
    • 1০৪ অক্টো, ২০১৭একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
      • মামলা নম্বর 1

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1প্রশাসনিক রিসিভার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Neville Barry Kahn
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    প্রশাসনিক রিসিভার
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    প্রশাসনিক রিসিভার
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0