INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামINFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04789693
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য ব্যবসা সহায়তা পরিষেবা কার্যক্রম ন.এ.সি. (82990) / প্রশাসনিক এবং সহায়ক পরিষেবা কার্যক্রম

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PRECIS (2361) LIMITED০৬ জুন, ২০০৩০৬ জুন, ২০০৩

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৭

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ২৮ জুন, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ২০ জুন, ২০১৮ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ জুন, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ জুন, ২০১৬

    ২০ জুন, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,004
    SH01

    ২৫ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Biif Corporate Services Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr John Ivor Cavill-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৪ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nestor Augusto Castillo Borrero এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জুল, ২০১৫ তারিখে Biif Corporate Services Limited-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH02

    ০১ জুল, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Dundas & Wilson North West Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ থেকে Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AFপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৭ জুন, ২০১৫

    ১৭ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,004
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ জুন, ২০১৪

    ২৭ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 5,004
    SH01

    ১১ নভে, ২০১৩ তারিখে Mr Nigel Wythen Middleton-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Biif Corporate Services Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    পরিচালক হিসাবে Mr Nestor Augusto Castillo Borrero-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Michael Forrest এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২১ মে, ২০১৪ তারিখে Mr Michael Forrest-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১১ নভে, ২০১৩ তারিখে Mr Michael Forrest-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর05372427
    128530180002
    CAVILL, John Ivor
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    পরিচালক
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    EnglandBritish152521640008
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    পরিচালক
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish156912990002
    LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LTD
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3388362
    90842510001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BELL, Andrew
    West Hill Park
    N6 6ND London
    39
    পরিচালক
    West Hill Park
    N6 6ND London
    39
    EnglandBritish136926040003
    BUSBY, Colin Ronald William
    34 Duloe Road
    PE19 8FQ St Neots
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    34 Duloe Road
    PE19 8FQ St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish109817700001
    CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    পরিচালক
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    EnglandBritish182601420001
    ELLIOTT, Christopher James
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    পরিচালক
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish31541950004
    FORREST, Michael
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    পরিচালক
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    United KingdomBritish169634490002
    HOGG, Cressida Mary
    W11
    পরিচালক
    W11
    EnglandBritish85643820001
    JENNINGS, Oliver James Wake
    Barclays Bank
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    পরিচালক
    Barclays Bank
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish86815910002
    JONES, Nigel Stuart
    3 Osprey Court
    Star Place
    E1W 1AG London
    পরিচালক
    3 Osprey Court
    Star Place
    E1W 1AG London
    British99472630001
    KING, Neil Edmund
    Annables Manor
    Annables Lane
    AL5 3PR Herpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Annables Manor
    Annables Lane
    AL5 3PR Herpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish115057710001
    LEATHES, Simon William De Mussenden
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    পরিচালক
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British9808160003
    MCCLATCHEY, Robert Sean
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    পরিচালক
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish140441450001
    MONTAGUE, Adrian Alastair, Sir
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    পরিচালক
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    United KingdomBritish70647930007
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    পরিচালক
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    পরিচালক
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    British59658050001
    VICKERSTAFF, Matthew
    2 Saint Andrews Avenue
    AL5 2RA Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    2 Saint Andrews Avenue
    AL5 2RA Harpenden
    Hertfordshire
    British75379800001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    কর্পোরেট পরিচালক
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর06793845
    188111290001
    PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    900019410001

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (England And Wales)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর06704479
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ জানু, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জানু, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৯ জানু, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of confirmation
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The shares and all related rights see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of confirmation
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The shares together with the related rights see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of charge and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জানু, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from infrastructure investors limited (in its capacity as manager of the borrower under the deed) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a first fixed charge its whole right title and interest in and to the shares together with the related rights, the investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ডিসে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The shares the related rights, the investments and the receivables,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed to deed of charge and assignment dated 21 december 2006
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The right title and interest in and to the shares and investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Other Finance Parties(The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৮ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of charge and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due by any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The shares together with the related rights; and the investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed to deed of charge and assignment dated 21 december 2006
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge its whole right,title and interest in and to the shares together with related rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Deed of charge and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge all the shares together with the related rights,all the investments together with the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge and assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the shares in eastbrook facilities holdings 2 limited, normanby healthcare group holdings limited, anavon holdings limited with the related rights meaning all dividends, distributions and other income and all investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Trustee for the Other Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জানু, ২০০৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৪ জুন, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0