OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামOPAL PORTFOLIO 3 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04824858
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ
    • ফি বা চুক্তিভিত্তিক ভিত্তিতে রিয়েল এস্টেট পরিচালনা (68320) / রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১২

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    7 পৃষ্ঠাLIQ13

    ২৯ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৯ সেপ, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২০ অক্টো, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Place Ducie Street Manchester M1 2TP থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ৩০ সেপ, ২০১৬ তারিখে

    LRESSP

    স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার সমাপ্তির নোটিশ

    47 পৃষ্ঠা1.4

    ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Richard James Spencer-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ০৪ জুন, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brett Alan Lashley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Brett Alan Lashley-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Craig Allan Mellor এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Gavin Robert Duncan এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Criag Allan Mellor এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ২৫ ফেব, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stuart Barrie Wall এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ মার্চ, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB থেকে The Place Ducie Street Manchester M1 2TPপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসনের সমাপ্তির নোটিশ

    74 পৃষ্ঠা2.32B

    ১০ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    67 পৃষ্ঠা2.24B

    রেজিস্ট্রারকে নোটিশ কোম্পানির স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থার কার্যকরী

    9 পৃষ্ঠা1.1

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১০ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    90 পৃষ্ঠা2.24B

    ১০ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    65 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠা2.31B

    ১৭ সেপ, ২০১৩ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    77 পৃষ্ঠা2.24B

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SPENCER, Richard James
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    পরিচালক
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish190526870001
    DRAPER, Abigail Sarah
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    সচিব
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    British107928180001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    মনোনীত সচিব
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MELLOR, Criag Allan
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    সচিব
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    British100890520001
    DUNCAN, Gavin Robert
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    পরিচালক
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish151512820001
    LASHLEY, Brett Alan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    পরিচালক
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandUnited States Of America196201790001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    পরিচালক
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish60906780002
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Group debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h land and buildings k/a condor works located on the north side of rusholme place, manchester t/n LA187336, by way of assignment the gross rents licence fees and other monies; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage the f/h property k/a wilmslow park wilmslow road manchester t/no GM683090 and opal court de montfort street leicester t/no LT27667 and including all rights and buildings fixtures fittings plant and machinery, the gross rents licence fees and other monies receivable, the benefit of all guarantees and all and any agreements. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ সেপ, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN362302, the f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN233238, the f/h property k/a phoenix house notte street plymouth and t/n DN303418. The gross rent licence fees and other monies , the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements relating to the property and the goodwill. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৮ মার্চ, ২০১৩প্রশাসন শুরু
    ২০ ফেব, ২০১৫প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    তারিখপ্রকার
    ১২ ডিসে, ২০১৪সিভিএ অনুমোদনের সভার তারিখ
    ২২ অক্টো, ২০১৫সিভিএ সম্পন্ন বা সমাপ্তির তারিখ
    কর্পোরেট স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা (সিভিএ)
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    4
    তারিখপ্রকার
    ৩০ সেপ, ২০১৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২২ আগ, ২০১৯ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0