THINC ENTITIES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTHINC ENTITIES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04836733
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    THINC ENTITIES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    THINC ENTITIES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    THINC ENTITIES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    THINC GROUP LIMITED১৭ জুল, ২০০৩১৭ জুল, ২০০৩

    THINC ENTITIES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    THINC ENTITIES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    THINC ENTITIES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ মে, ২০১৪

    ১৫ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    পরিচালক হিসাবে David Richard Cheeseman-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Graham Harvey এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    অডিটরের পদত্যাগ

    2 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    3 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    3 পৃষ্ঠাAUD

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ২৭ ডিসে, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.00
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Reduction of share premium account and miscellaneous reserve balance 27/12/2012
    RES13

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Christopher Graham Bobby-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Philip Anderson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Graham Harvey-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৩ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ২৩ এপ্রি, ২০১০ তারিখে Jeremy Peter Small-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    THINC ENTITIES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    সচিব
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    British67168210001
    BOBBY, Christopher Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    পরিচালক
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish170592990001
    CHEESEMAN, David Richard
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    পরিচালক
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritish132416500001
    HARKIN, Neil Michael
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    সচিব
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    British146701610001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    সচিব
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    British130449650001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ANDERSON, Philip John
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    পরিচালক
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    UkBritish79136250001
    BALDWIN, Keith Reginald
    Sandridge Lodge
    Bromham
    SN15 2JN Chippenham
    Wiltshire
    পরিচালক
    Sandridge Lodge
    Bromham
    SN15 2JN Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish7401430002
    BAYLISS, Keith Ronald
    3 Chesterford House
    28 Store Street
    WC1E 7BS London
    পরিচালক
    3 Chesterford House
    28 Store Street
    WC1E 7BS London
    British55337400002
    BOYLE, Nicholas
    2 Mount Pleasant
    Stanmills
    BT9 5DS Belfast
    County Antrim
    পরিচালক
    2 Mount Pleasant
    Stanmills
    BT9 5DS Belfast
    County Antrim
    British141649010001
    CHAMBERLAIN, Simon John
    Manor Cottage
    Crackington Haven
    EX23 0JG Bude
    Cornwall
    পরিচালক
    Manor Cottage
    Crackington Haven
    EX23 0JG Bude
    Cornwall
    EnglandBritish133883740012
    EVERILL, Jonathon Robert Edwin
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    পরিচালক
    Sandbanks Road
    BH14 8EY Poole
    277
    Dorset
    British105488120003
    HARKIN, Neil Michael
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    White House
    Dunnington Common Dunnington
    YO19 5LS York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish146701610001
    HARRAGAN, Stephen William
    36 Birch Lane
    CM4 9NA Stock
    Essex
    পরিচালক
    36 Birch Lane
    CM4 9NA Stock
    Essex
    United KingdomBritish16510590003
    HARVEY, Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    পরিচালক
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United KingdomBritish168974600001
    PIERCE, Raymond Francis
    St Wilfreds 42 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    পরিচালক
    St Wilfreds 42 Ferndale Road
    RH15 0HG Burgess Hill
    West Sussex
    EnglandBritish3231870001
    RENNISON, Roderic Henry Patrick
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Westmill Lane
    Ickleford
    SG5 3RP Hitchin
    Old Westmill Farmhouse
    Hertfordshire
    EnglandBritish130449650001
    TAYLOR, Gregg
    Meadowvale
    Wellington Hill, High Beach
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    পরিচালক
    Meadowvale
    Wellington Hill, High Beach
    IG10 4AH Loughton
    Essex
    United KingdomBritish93705800003
    TROTTER, Timothy Hugh Southcombe
    Field Burcote House
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Field Burcote House
    Duncote
    NN12 8AH Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish86031170001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    THINC ENTITIES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Right, title and interest in and to the shares and any securities. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of second fixed charge its entire right title and interest in and to the shares and to any securities and all dividends monies and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Prudential UK Services Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a the guard house, fulford road, york, level 2 vitners place, 68 upper thames street, london, park house west, heatcote road, camberley t/no SY741619 for further property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Prudential UK Services Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £10,674.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Trustees of the National Heritage Memorial Fund
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Assignment of debts by way of security
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or thinc finance limited to the charge on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the future rights, titles and interests in and benefits of the company whatsoever in the debts, together with the benefit of any and all intermediary contracts or agency agreements.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over cash deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums (denominated in whatever currency) together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit of the bank account of the company with bos. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২১ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0