BRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04845777
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7012) /

    BRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5 Albany Courtyard
    Picadilly
    W1J 0HF London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    THREE BRINDLEYPLACE (NO.2) LIMITED২৫ জুল, ২০০৩২৫ জুল, ২০০৩

    BRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১১

    BRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    4 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে David Partridge এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Anthony Giddings এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Robert Evans এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Andre Gibbs এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৫ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    11 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ আগ, ২০১০

    ০৫ আগ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    33 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    স্মারকলিপি এবং/অথবা সংঘের নিবন্ধ পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Sction 175 09/03/2010
    RES13

    ১৮ জুল, ২০০৯ তারিখে Mr Stephen Tillman-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH01

    ০২ সেপ, ২০০৯ তারিখে Roger Nigel Madelin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ সেপ, ২০০৯ তারিখে Mr Andre Gibbs-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH01

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    13 পৃষ্ঠা395

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    12 পৃষ্ঠা395

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    BRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PROWER, Aubyn James Sugden
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    সচিব
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    British45043490002
    SADLER, Anita Joanne
    8 Eddiscombe Road
    SW6 4UA London
    সচিব
    8 Eddiscombe Road
    SW6 4UA London
    British104279900001
    MADELIN, Roger Nigel
    Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    23
    Surrey
    পরিচালক
    Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    23
    Surrey
    United KingdomBritish11621570005
    PROWER, Aubyn James Sugden
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    পরিচালক
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    United KingdomBritish45043490002
    TAYLOR, Gary John
    21 South Road
    DY9 0JT West Hagley
    Worcestershire
    পরিচালক
    21 South Road
    DY9 0JT West Hagley
    Worcestershire
    United KingdomBritish161266610001
    TILLMAN, Stephen
    Riverside House
    Riverside
    TW1 3DJ Twickenham
    1a
    Middlesex
    Gbr
    পরিচালক
    Riverside House
    Riverside
    TW1 3DJ Twickenham
    1a
    Middlesex
    Gbr
    United KingdomBritish58659580006
    PAILEX SECRETARIES LIMITED
    20 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    কর্পোরেট সচিব
    20 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    74551790001
    EVANS, Robert Michael
    66a Holtspur Top Lane
    HP9 1DT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    66a Holtspur Top Lane
    HP9 1DT Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish99016100002
    GIBBS, Andre
    10 Hampstead Lane
    Highgate
    N6 4RT London
    West Cottage
    পরিচালক
    10 Hampstead Lane
    Highgate
    N6 4RT London
    West Cottage
    United KingdomBritish99016080003
    GIDDINGS, Anthony Jan
    The Old Alms House
    Cage End Hatfield Broad Oak
    CM22 7HW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Old Alms House
    Cage End Hatfield Broad Oak
    CM22 7HW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritish56956610003
    PARTRIDGE, David John Gratiaen
    The Barn
    Boundary Farm
    NR24 2NS Gunthorpe
    Norfolk
    পরিচালক
    The Barn
    Boundary Farm
    NR24 2NS Gunthorpe
    Norfolk
    United KingdomBritish41215410004
    PAILEX NOMINEES LIMITED
    20 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    কর্পোরেট পরিচালক
    20 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    74551780001

    BRINDLEYPLACE CO-NOMINEE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Supplemental charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property known as the apartments part ground floor and floors 9-13 (inclusive) 8 brindley place birmingham t/n WM826943, including all buildings fixtures and fixed plant and machinery, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC (Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land and buildings on the north west side of broad street, birmingham t/no WM491380, l/h three brindley place, birmingham t/no WM682940, l/h four brindley place, birmingham t/no WM767322 for details of further property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুন, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H four brindleyplace birmingham t/no WM767322, l/h number five brindleyplace t/no WM625319 and l/h six brindleyplace birmingham t/no WM771278 for details of further properties charged please refer to form 395 all buildings fixtures fittings fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জুন, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ অক্টো, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a number three brindleyplace, birmingham t/no WM682940 all interest in all freehold and leashold property present and future fixed charge all plant and machinery, monies standing to any account, insurances, book and other debts, guarantees, undertakings, covenats and warranties, rights under lease document and hedging agreement, goodwill, uncalled capital, shares and all related rights , all rental income and guarantee of rental income, proceeds of sale floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC (The Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৩ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০০২
    অর্জিত হয়েছে ২৬ মে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £200,000,000 due or to become due from the company to
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Part ten brindleyplace, birmingham t/no WM822078; ten brindleyplace, birmingham t/no WM771274; part eight brindleyplace, birmingham t/no WM822077, for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Investment Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুন, ২০০৫অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0