MAYPOLE BANBURY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMAYPOLE BANBURY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 04988209
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MAYPOLE BANBURY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7320) /

    MAYPOLE BANBURY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    BAKER TILLY RESTRUCTURING & RECOVERY LLP
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MAYPOLE BANBURY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    A J LEISURE HOTELS LIMITED.০৮ এপ্রি, ২০০৪০৮ এপ্রি, ২০০৪
    READ & MCEWEN LIMITED০৮ ডিসে, ২০০৩০৮ ডিসে, ২০০৩

    MAYPOLE BANBURY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৯

    MAYPOLE BANBURY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২৬ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    14 পৃষ্ঠা2.24B

    ২৬ অক্টো, ২০১১ তারিখে প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    14 পৃষ্ঠা2.35B

    প্রশাসক কর্তৃক পদত্যাগের বিজ্ঞপ্তি

    8 পৃষ্ঠা2.39B

    প্রতিস্থাপন/অতিরিক্ত প্রশাসক নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি

    14 পৃষ্ঠা2.40B

    ২৬ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    33 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    1 পৃষ্ঠাF2.18

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    45 পৃষ্ঠা2.17B

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Simon Anthony Bentley-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Jacob Lew এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৮ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ ডিসে, ২০০৯

    ২২ ডিসে, ২০০৯ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Tristan David Mcewen-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৮ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Mr Alastair Peter Mcewen-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    MAYPOLE BANBURY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BENTLEY, Simon Anthony
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    Glen Wood House
    সচিব
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    Glen Wood House
    150743930001
    BENTLEY, Simon Anthony
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    পরিচালক
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    United KingdomBritishCompany Director3007630001
    MCEWEN, Alastair Peter
    Lottie Cottage
    St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Lottie Cottage
    St Thomas Street
    OX15 0SY Deddington
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director16685200004
    MCEWEN, Tristan David
    The Old Post Office
    1 Old Post Office Court
    PE31 6GW Nethergate Street Harpley
    Norfolk
    পরিচালক
    The Old Post Office
    1 Old Post Office Court
    PE31 6GW Nethergate Street Harpley
    Norfolk
    EnglandBritishGeneral Manager170787840001
    BUTCHER, Michael Leonard
    23 Harefield
    East Leake
    LE12 6RE Loughborough
    Leicestershire
    সচিব
    23 Harefield
    East Leake
    LE12 6RE Loughborough
    Leicestershire
    BritishAccountant43307770003
    LEW, Jacob Stephen
    Welbeck Mansions
    Inglewood Road
    NW6 1QX London
    Flat 4c
    United Kingdom
    সচিব
    Welbeck Mansions
    Inglewood Road
    NW6 1QX London
    Flat 4c
    United Kingdom
    British131264200001
    MH SECRETARIES LIMITED
    12 Great James Street
    WC1N 3DR London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    12 Great James Street
    WC1N 3DR London
    900021100001
    BUTCHER, Michael Leonard
    23 Harefield
    East Leake
    LE12 6RE Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    23 Harefield
    East Leake
    LE12 6RE Loughborough
    Leicestershire
    BritishAccountant43307770003
    READ, Graham John
    190 Norsey Road
    CM11 1DB Billericay
    Essex
    পরিচালক
    190 Norsey Road
    CM11 1DB Billericay
    Essex
    EnglandBritishManaging Director97362430001
    MH DIRECTORS LIMITED
    12 Great James Street
    WC1N 3DR London
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    12 Great James Street
    WC1N 3DR London
    900021090001

    MAYPOLE BANBURY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property with t/no ON110782 and forming part of the property k/a the wroxham house hotel 4 & 5 silver street wroxton oxfordshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Clydesdale Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £250,000 and all other monies due or to become due
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Wroxton house hotel 4 & 5 silver street wroxton oxfordshire t/no ON110782.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • N a Williams, R H Williams and V M Kuhle
    ব্যবসায়
    • ০৩ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ জানু, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property known as the wroxton house hotel, 4 and 5 silver street, wroxton t/n ON110782. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MAYPOLE BANBURY LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৭ অক্টো, ২০১০প্রশাসন শুরু
    ২৬ অক্টো, ২০১১প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Bruce Alexander Mackay
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    অভ্যাসকারী
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Simon Peter Bower
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    অভ্যাসকারী
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    অভ্যাসকারী
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0