AMWORTH LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামAMWORTH LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05033773
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    AMWORTH LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (3710) /
    • (3720) /
    • (4011) /
    • (7487) /

    AMWORTH LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    AMWORTH LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BKP DRY WASTE LIMITED১৪ এপ্রি, ২০০৪১৪ এপ্রি, ২০০৪
    IMAGEFLIGHT LIMITED০৪ ফেব, ২০০৪০৪ ফেব, ২০০৪

    AMWORTH LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৬

    AMWORTH LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২৭ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.72

    ১৩ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    13 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    13 পৃষ্ঠা2.34B

    ২২ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    11 পৃষ্ঠা2.24B

    ২২ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    9 পৃষ্ঠা2.24B

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    9 পৃষ্ঠা2.24B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    4 পৃষ্ঠা2.23B

    বিবৃতির বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠা2.16B

    ক্রেডিটরদের সভার ফলাফল

    29 পৃষ্ঠা2.23B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    27 পৃষ্ঠা2.17B

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    1 পৃষ্ঠা2.17B

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা403a

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed bkp dry waste LIMITED\certificate issued on 05/03/07
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    legacy

    8 পৃষ্ঠা395

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    6 পৃষ্ঠা395

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    AMWORTH LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BROWN, Denise Jane
    2 Church Farm Cottages
    West Tytherley
    SP5 1JZ Salisbury
    Wiltshire
    সচিব
    2 Church Farm Cottages
    West Tytherley
    SP5 1JZ Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector91496080001
    HEALEY, Nicholas John Scott
    The Granary House
    Bickton
    SP6 2HA Fordingbridge
    Hampshire
    পরিচালক
    The Granary House
    Bickton
    SP6 2HA Fordingbridge
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector23447670003
    KELLY, John Joseph
    27 Carisbrooke Court
    Romsey
    SO51 7JQ Romsey
    Hampshire
    পরিচালক
    27 Carisbrooke Court
    Romsey
    SO51 7JQ Romsey
    Hampshire
    EnglandBritishDirector97405370001
    M & B SECRETARIES LIMITED
    11 The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    Hampshire
    কর্পোরেট সচিব
    11 The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    Hampshire
    91006920001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    GRINHAM, David Hanley, Mr.
    Ravenscroft Way
    Botley
    SO3Z 2FZ Southampton
    8
    Hampshire
    পরিচালক
    Ravenscroft Way
    Botley
    SO3Z 2FZ Southampton
    8
    Hampshire
    EnglandBritishGeneral Manager139800100001
    WHATLEY, David George
    Maritime House
    Hook Park Road Warash
    SO31 8DH Southampton
    Hampshire
    পরিচালক
    Maritime House
    Hook Park Road Warash
    SO31 8DH Southampton
    Hampshire
    BritishDirector44098950001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    M & B NOMINEES LIMITED
    11 The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    Hampshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    11 The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    Hampshire
    86028110001

    AMWORTH LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any associate on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • State Securities PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুল, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুল, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cattles Invoice Finance (Oxford) Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ জুল, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ মে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    All assets debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    AMWORTH LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৩ মার্চ, ২০০৭প্রশাসন শুরু
    ০২ এপ্রি, ২০০৯প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Nigel Ian Fox
    Rsm Tenon Restructuring Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    Rsm Tenon Restructuring Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Carl Stuart Jackson
    Tenon Recovery
    Highfield Court
    SO53 3TZ Tollgate
    Chandlers Ford Eastleigh, Hampshire
    অভ্যাসকারী
    Tenon Recovery
    Highfield Court
    SO53 3TZ Tollgate
    Chandlers Ford Eastleigh, Hampshire
    2
    তারিখপ্রকার
    ০২ এপ্রি, ২০০৯ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ০৭ মার্চ, ২০১০ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Nigel Ian Fox
    Rsm Tenon Restructuring Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    অভ্যাসকারী
    Rsm Tenon Restructuring Highfield Court Tollgate
    Chandlers Ford
    SO53 3TZ Eastleigh
    Hampshire
    Carl Stuart Jackson
    Tenon Recovery
    Highfield Court
    SO53 3TZ Tollgate
    Chandlers Ford Eastleigh, Hampshire
    অভ্যাসকারী
    Tenon Recovery
    Highfield Court
    SO53 3TZ Tollgate
    Chandlers Ford Eastleigh, Hampshire

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0