HCCAH LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHCCAH LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05096889
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HCCAH LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    HCCAH LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HCCAH LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ALEXANDRA HOUSE PROPERTIES LIMITED০১ জুন, ২০০৪০১ জুন, ২০০৪
    TRUSHELFCO (NO.3043) LIMITED০৬ এপ্রি, ২০০৪০৬ এপ্রি, ২০০৪

    HCCAH LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    HCCAH LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    HCCAH LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ১০ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr James Alexander Burrell-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    চার্জ 7 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ নিবন্ধন 050968890008, ১২ জুন, ২০১৪ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    91 পৃষ্ঠাMR01

    চার্জ 5 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 6 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৭ এপ্রি, ২০১৪

    ০৭ এপ্রি, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    ৩১ জানু, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Geraldine Josephine Gallagher-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ জানু, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Matthew Edward Bennison এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ জানু, ২০১৪ তারিখে সচিব হিসাবে Matthew Edward Bennison এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    11 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    18 পৃষ্ঠাMG01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৬ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    14 পৃষ্ঠাMG01

    হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    1 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Matthew Edward Bennison-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Mr Matthew Edward Bennison-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে Timothy Doubleday এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    HCCAH LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritish192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrish185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish89557480002
    TROY, Anthony Gerard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrish104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161805270001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    সচিব
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156121500001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    সচিব
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    SOLOMAN, Sheila Margaret
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    সচিব
    5 The Green
    Hardingstone
    NN4 7BU Northampton
    Northamptonshire
    British45253560008
    TRUSEC LIMITED
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    2 Lambs Passage
    EC1Y 8BB London
    900007200001
    ANDERSON, Peter George
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    পরিচালক
    23 Cheshire Road
    OX9 3LQ Thame
    Oxfordshire
    British70304810001
    BELLONE, Norman Edward
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Gardens Cottage
    Bagendon
    GL7 7DU Cirencester
    Gloucestershire
    British126414070001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish108534390002
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    পরিচালক
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritish124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritish132613500001
    PEEKE, Alexander
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    পরিচালক
    7 Milton Lodge
    Whitton Road
    TW1 1BU Twickenham
    British98031180001
    STOKER, Louise Jane
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    পরিচালক
    2nd Floor Flat
    45 Hillfield Road, West Hampstead
    NW6 1QD London
    British96079800001
    WHITE, Graham Peter
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    পরিচালক
    Copsem Lane
    KT22 0NT Oxshott
    Woodlands House
    Surrey
    United KingdomBritish4934020002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    14 St Marys Court
    Tingewick
    MK18 4RE Buckingham
    Buckinghamshire
    British61053330001

    HCCAH LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুন, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০১৪
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cbre Loan Servicing Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুন, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    English law deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৭ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৩ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২২ জুন, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC as 'Security Agent'
    ব্যবসায়
    • ০৬ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of accession to the composite guarantee and debenture dated 18 december 2003
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ফেব, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due by each charging company to each of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Princess alexandra raf hospital, wroughton, nr swindon, wiltshire t/ns WT213965 and WT216467,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ০২ ফেব, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ২০০৩
    অর্জিত হয়েছে ২৪ জানু, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each charging company to each of the lenders
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a alexander house, wroughton, near swindon, wiltshire t/n WT2139665 and WT216467.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ২০০৫অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০৪ মে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জানু, ২০০০
    অর্জিত হয়েছে ২৪ জানু, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land containing 29.830 hectares or thereabouts situated wroughton swindon wiltshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Secretary of State for Defence
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ২০০৫অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0