PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05131340
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Southport Business Park
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    EVER 2403 LIMITED১৮ মে, ২০০৪১৮ মে, ২০০৪

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২২

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ১১ মে, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৩ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ms Emma Jane Rawlinson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৩ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ms Rebecca Jane Shepherd-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০১ নভে, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Byrne এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    215 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    ১৬ মে, ২০২২ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    ২২ ফেব, ২০২২ তারিখে সচিব হিসাবে Dean Clarke এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ২২ ফেব, ২০২২ তারিখে সচিব হিসাবে Ardonagh Corporate Secretary Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    195 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০১ জুল, ২০২১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.00
    3 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর03702575
    288842300001
    EVANS, Robert Ieuan
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    United KingdomBritish257339940001
    RAWLINSON, Emma Jane
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United Kingdom
    পরিচালক
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish308195960001
    SHEPHERD, Rebecca Jane
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United Kingdom
    পরিচালক
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritish191546550001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    সচিব
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    169016440001
    CLARKE, Dean
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    সচিব
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    253940220001
    EVANS, Paul William John
    2 Stokes Hall Avenue
    Leyland
    PR25 3FA Preston
    Lancashire
    সচিব
    2 Stokes Hall Avenue
    Leyland
    PR25 3FA Preston
    Lancashire
    British44044870002
    GIFFORD, Nicola
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    সচিব
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    147962050001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    সচিব
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    249087370001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    সচিব
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    222330450001
    JOHNSTON, Graham Hamilton
    13 Glencairn Park Road
    GL50 2ND Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    13 Glencairn Park Road
    GL50 2ND Cheltenham
    Gloucestershire
    British120581050001
    OWENS, Jennifer
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    সচিব
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    183285380001
    PENDER, Stuart Macpherson
    Dalnair House
    47 Chalton Road
    FK9 4EF Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    সচিব
    Dalnair House
    47 Chalton Road
    FK9 4EF Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    British86071320001
    POWELL, Vernon David
    18 Sunnybank Road
    Helmshore
    BB4 4PF Rossendale
    Lancashire
    সচিব
    18 Sunnybank Road
    Helmshore
    BB4 4PF Rossendale
    Lancashire
    British65823910002
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    BOULGER, Graham
    2 Church Gardens
    Euxton
    PR7 6LF Chorley
    Lancashire
    পরিচালক
    2 Church Gardens
    Euxton
    PR7 6LF Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish85225620001
    BYRNE, Jonathan
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    পরিচালক
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    United KingdomBritish261430150001
    CHRISTOPHERS, Michael
    7 Chiltern Close
    Park Hill
    CR0 5LZ Croydon
    Surrey
    পরিচালক
    7 Chiltern Close
    Park Hill
    CR0 5LZ Croydon
    Surrey
    British56738180003
    COWAN, John
    47 Montagu Square
    W1H 2LW London
    পরিচালক
    47 Montagu Square
    W1H 2LW London
    United KingdomBritish109138540001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish59873490009
    DAVIES, Mark
    12 Pinfold Lane
    PR8 3QH Ainsdale
    Merseyside
    পরিচালক
    12 Pinfold Lane
    PR8 3QH Ainsdale
    Merseyside
    British117122470001
    DIXON, Richard John
    6 Woodthorpe Manor
    Sandal
    WF2 6SY Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    6 Woodthorpe Manor
    Sandal
    WF2 6SY Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish109138230001
    EGAN, Scott
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish169209310001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomCypriot167795710001
    EVANS, Paul William John
    2 Stokes Hall Avenue
    Leyland
    PR25 3FA Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    2 Stokes Hall Avenue
    Leyland
    PR25 3FA Preston
    Lancashire
    British44044870002
    HODGES, Mark Steven
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish58444370003
    HOMER, Andrew Charles
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish13483140003
    JOHNSON, Timothy David
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish140206600001
    JOHNSTON, Graham Hamilton
    13 Glencairn Park Road
    GL50 2ND Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    13 Glencairn Park Road
    GL50 2ND Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish120581050001
    KENNEDY, Eamonn
    18 Lyme Road
    Disley
    SK12 2LL Stockport
    পরিচালক
    18 Lyme Road
    Disley
    SK12 2LL Stockport
    EnglandBritish75039450002
    LANE SMITH, Roger
    The Lanebridge Property Fund
    The Coach House Fulshaw Hall
    SK9 1RL Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    The Lanebridge Property Fund
    The Coach House Fulshaw Hall
    SK9 1RL Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish109062130001
    LYONS, Alastair David
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish192311310001
    MACIVER, Kenneth
    The Poplars
    The Green
    TN12 8JS Horsmonden
    Kent
    পরিচালক
    The Poplars
    The Green
    TN12 8JS Horsmonden
    Kent
    British70920700002
    MARTIN, Kay Alison
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish228129420001
    MUGGE, Mark Stephen
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    Paymentshield House
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish162920630005

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Paymentshield Group Holdings Limited
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Wight Moss Way
    PR8 4HQ Southport
    Southport Business Park
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মCompany Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House Cardiff
    নিবন্ধন নম্বর5919794
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    PAYMENTSHIELD HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুন, ২০২০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুন, ২০২০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank, N.A., London Branch
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুন, ২০২০একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৩ জুল, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০১৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ২০১৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    N/A.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank, N.A., London Branch
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ২০১৮একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৩ জুল, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ আগ, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ আগ, ২০১৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    N/A.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citibank, N.A., London Branch
    ব্যবসায়
    • ১০ আগ, ২০১৭একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৩ জুল, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ এপ্রি, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ২০১৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    ব্যবসায়
    • ২২ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৭ জুল, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মে, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ২০১৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৯ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৩ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১১ ফেব, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ২৫ ফেব, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১১ জুল, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of accession
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুল, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for and on Behalf of the Finance Parties (The Securitytrustee)
    ব্যবসায়
    • ২১ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Aviva Insurance Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal & Sun Aliance Insurance PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ সেপ, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting in Its Capacity as Security Trustee Forthe Security Beneficiaries the "Security Trustee"
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over cash collateral account
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the lng bank under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any credit balance on the secured account number 06037903 sort code 12-08-95 and all entitlements to interest the right to repayment and all other rights benefits and proceeds thereof. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting in Its Capacity as Security Trustee Forand on Behalf of the Lng Bank the "Security Trustee"
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0