PIMS GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPIMS GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05280931
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PIMS GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • সিউরেজ ব্যবস্থা (37000) / জল সরবরাহ, স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনরুদ্ধার কার্যক্রম

    PIMS GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Private Road No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PIMS GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BROOMCO (3609) LIMITED০৯ নভে, ২০০৪০৯ নভে, ২০০৪

    PIMS GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জুল, ২০১৩

    PIMS GROUP LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    PIMS GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ২০ নভে, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Karen Linda Pay এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৮ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephane Rousselot-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১১ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robert Grund এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে সচিব হিসাবে Melanie Linda Sowter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Melanie Linda Sowter এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ জুল, ২০১৪ থেকে ৩০ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ জানু, ২০১৫

    ০৯ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 554,545.43
    SH01

    ২৭ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Karen Linda Pay-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Robert Grund-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৭ নভে, ২০১৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter John Lewington এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৭ অক্টো, ২০১৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 554,545.45
    4 পৃষ্ঠাSH01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ০৩ নভে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 0.01
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share premium account cancelled 17/10/2014
    RES13

    পূর্ণ হিসাব ৩১ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৭ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ ডিসে, ২০১৩

    ১৬ ডিসে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 554,545.43
    SH01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ এপ্রি, ২০১৩ থেকে ৩১ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পরিচালক হিসাবে Charles White এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    সচিব হিসাবে Michael Bell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    সচিব হিসাবে Mrs Melanie Linda Sowter-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    PIMS GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ROUSSELOT, Stephane
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    পরিচালক
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandFrenchFinance Director202797810001
    BACKHOUSE, Christopher Mark
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    সচিব
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant Company D101749180003
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    সচিব
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    BritishDirector90062470004
    FAY, Sean Ernan
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    সচিব
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    IrishCompany Director84925400001
    SOWTER, Melanie Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    সচিব
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    179710270001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    কর্পোরেট মনোনীত সচিব
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BACKHOUSE, Christopher Mark
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant Company D101749180003
    BANKS, Francis Wilson
    Unit 1 106 Hawley Lane
    Farnborough
    GU14 8JE Hants
    পরিচালক
    Unit 1 106 Hawley Lane
    Farnborough
    GU14 8JE Hants
    United KingdomBritishDirector152084560001
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    পরিচালক
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector90062470004
    CANNING, Paul
    20 Mascotte Road
    Putney
    SW15 1NN London
    পরিচালক
    20 Mascotte Road
    Putney
    SW15 1NN London
    BritishInvestment Director109698250001
    FAY, Sean Ernan
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    পরিচালক
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    United KingdomIrishCompany Director84925400001
    GRICE, Ian Michael
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    পরিচালক
    Heronshaw
    Oldbury Lane
    TN15 9DE Ightham
    Kent
    United KingdomBritishCompany Chairman44883010002
    GRUND, Robert
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    পরিচালক
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandAustrianFinance Director182385330001
    LAWRENCE, Kenneth William
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    পরিচালক
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    United KingdomBritishDirector40388380001
    LEWINGTON, Peter John
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    পরিচালক
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director137420410001
    PAY, Karen Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    পরিচালক
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandBritishHr Director176337440001
    SOWTER, Melanie Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    পরিচালক
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Director113352030002
    TAYLOR, Brian Thomas
    Spring Lodge
    Hook Heath
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Spring Lodge
    Hook Heath
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    BritishChairman86150710002
    WHITE, Charles Liddell
    71 The Chase
    BH31 7DE Verwood
    Dorset
    পরিচালক
    71 The Chase
    BH31 7DE Verwood
    Dorset
    EnglandBritishDirector54824060001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    কর্পোরেট মনোনীত পরিচালক
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    PIMS GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A guarantee and security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the security trustee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right title and interest in the mortgaged property together with allbuildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    ব্যবসায়
    • ১৭ এপ্রি, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ফেব, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A master guarantee and security
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ মার্চ, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All its right title and interest in the mortgaged property all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    ব্যবসায়
    • ২৫ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ফেব, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage of shares
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its stock,shares,bonds,debentures,debenture stock,loan stock,unit trust investments,certificates of deposit and other securities of any description see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ফেব, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and the subsidiaries to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gresham LLP as Trustee for Itself and the Registered Holders from Time to Time of Notes Issuedunder the Gresham Loan Note Instrument (In Suchcapacity, the Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জানু, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ফেব, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ ডিসে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The keyman policy in respect of charles white dated 3 december 2004 issued by friends provident life and pensions with policy number Q2851614 in respect of critical illness and disability and st james's place UK PLC with policy number 45C16M98 in respect of life cover and any other policy or policies required to be effected by the charge together with the rights and benefits accrued or accruing under these policies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ ফেব, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0