BROMSGROVE STREET LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBROMSGROVE STREET LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 05365574
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BROMSGROVE STREET LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    BROMSGROVE STREET LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BROMSGROVE STREET LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    BROMSGROVE STREET LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    10 পৃষ্ঠা4.71
    A1O9VOXE

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01
    A1IF96UO

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70
    A1IF96UW

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600
    A1IF96U8

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৮ সেপ, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ মার্চ, ২০১২

    ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01
    X14NFN9U

    ১২ জানু, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Colin Richard Clapham-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03
    X11CMM56

    ১২ জানু, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Karen Lorraine Atterbury এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02
    X11CMM4Y

    ০৫ ডিসে, ২০১১ তারিখে Simon James Brown-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XJ590ZTM

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA
    ABLSSXE1

    ২২ জুল, ২০১১ তারিখে Ingrid Ruth Skinner-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X9NMTW15

    ০১ সেপ, ২০১০ তারিখে David Andrew Reid-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X9J71W0T

    ২১ জুল, ২০১১ তারিখে David Andrew Reid-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X9HGUW0T

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01
    X9913T1D

    ২৮ মার্চ, ২০১১ তারিখে Karen Lorraine Atterbury-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH03
    X6SFASV7

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    XSF62RPS

    ১২ অক্টো, ২০১০ তারিখে Ingrid Ruth Gelley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XMBEZO61

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02
    AXKUNO2Y

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02
    AXKUOO2Z

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02
    AXKUPO20

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02
    AXKUQO21

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA
    A16PHNU4

    ২৭ জুল, ২০১০ তারিখে Mr Vahid Alaghband-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XPGHHM1N

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    XN8G5HKE

    BROMSGROVE STREET LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    সচিব
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    166216640001
    ALAGHBAND, Nader
    31-32 Kensington Park Gardens
    W11 2QS London
    Flat 6
    পরিচালক
    31-32 Kensington Park Gardens
    W11 2QS London
    Flat 6
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishDirector120915300001
    ALAGHBAND, Vahid
    Stanhope Gate
    W1K 1AH London
    5
    United Kingdom
    পরিচালক
    Stanhope Gate
    W1K 1AH London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector5674390001
    BROWN, Simon James
    101-135
    Kings Road
    CM14 4DR Brentwood
    Kings House
    Essex
    United Kingdom
    পরিচালক
    101-135
    Kings Road
    CM14 4DR Brentwood
    Kings House
    Essex
    United Kingdom
    BritainBritishRegional Managing Director46898530007
    REID, David Andrew
    Stanhope Gate
    W1K 1AH London
    5
    United Kingdom
    পরিচালক
    Stanhope Gate
    W1K 1AH London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector155269870001
    SKINNER, Ingrid Ruth
    New Bond Street
    W1S 1SB London
    80
    United Kingdom
    পরিচালক
    New Bond Street
    W1S 1SB London
    80
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director133605100002
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    সচিব
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British175715660001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Other135442010007
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    সচিব
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    সচিব
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    British130306120001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    সচিব
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    BritishDirector76844970003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    সচিব
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    BritishSolicitor/Company Secretary120602100002
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    সচিব
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    BritishSolicitor8364990001
    CML SECRETARIES LIMITED
    2 Piries Place
    RH12 1EH Horsham
    West Sussex
    কর্পোরেট সচিব
    2 Piries Place
    RH12 1EH Horsham
    West Sussex
    74740960001
    ATKIN, Peter Neil
    Hurst Dene
    New Place
    RH20 1AT Pulborough
    West Sussex
    পরিচালক
    Hurst Dene
    New Place
    RH20 1AT Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritishManaging Director10294000001
    COOK, Richard John
    23 Hawthorne Drive
    School Aycliffe
    DL5 6GH Darlington
    County Durham
    পরিচালক
    23 Hawthorne Drive
    School Aycliffe
    DL5 6GH Darlington
    County Durham
    United KingdomBritishProject Director178588500001
    DODDS, Graeme James
    16 Second Avenue
    CO13 9ER Frinton On Sea
    Essex
    পরিচালক
    16 Second Avenue
    CO13 9ER Frinton On Sea
    Essex
    EnglandBritishDirector146495490001
    FREEMAN, Emma Louise
    13 Beverley Path
    Barnes
    SW13 0AL London
    পরিচালক
    13 Beverley Path
    Barnes
    SW13 0AL London
    BritishDirector113500840001
    HAYS, Richard William
    2 Linfold Close
    CM7 9FB Braintree
    Essex
    পরিচালক
    2 Linfold Close
    CM7 9FB Braintree
    Essex
    United KingdomBritishDirector90336020002
    HAYS, Richard William
    2 Linfold Close
    CM7 9FB Braintree
    Essex
    পরিচালক
    2 Linfold Close
    CM7 9FB Braintree
    Essex
    United KingdomBritishCommercial Director90336020002
    MARTIN, Roderick Adrian
    30 Juniper Close
    RH8 0RX Oxted
    Surrey
    পরিচালক
    30 Juniper Close
    RH8 0RX Oxted
    Surrey
    BritishDirector105672190002
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    পরিচালক
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritishDirector75750250002
    SOUTHCOMBE, Michael Arthur
    5 Mackie Avenue
    BN6 8NH Hassocks
    West Sussex
    পরিচালক
    5 Mackie Avenue
    BN6 8NH Hassocks
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector33313590001
    TILLOTSON, David Gregory
    Stubbards Croft
    Vine Street
    CM7 4SR Great Bardfield
    Essex
    পরিচালক
    Stubbards Croft
    Vine Street
    CM7 4SR Great Bardfield
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director118374930001
    TURNER, Niki Jayne
    76 Rydal Gardens
    TW3 2JH Whitton
    Middlesex
    পরিচালক
    76 Rydal Gardens
    TW3 2JH Whitton
    Middlesex
    BritishDirector99481440001
    WOOLSEY, Richard John
    33 Victoria Wharf 46 Narrow Street
    E14 8DD London
    পরিচালক
    33 Victoria Wharf 46 Narrow Street
    E14 8DD London
    EnglandBritishDirector111162100001

    BROMSGROVE STREET LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Its entire right title and interest in and to the contract. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of assignment
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ সেপ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Its entire right title and interest in and to the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৭ সেপ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ আগ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land and buildings at hurst street bromsgrove street pershore street and claybrook street birmingham t/n WM857697. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ আগ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ আগ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ আগ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    BROMSGROVE STREET LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৮ মার্চ, ২০১৩ভেঙে গেছে
    ১৮ সেপ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0